OLDNAME NO. 397 LIMITED

OLDNAME NO. 397 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaOLDNAME NO. 397 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02589210
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    • (3002) /

    Onde fica OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DIAGNOSYS LIMITED11/06/199111/06/1991
    D.C.A.-I.L. SYSTEMS LIMITED20/05/199120/05/1991
    LETTERDETAIL LIMITED07/03/199107/03/1991

    Quais são as últimas contas de OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2007

    Quais são as últimas submissões para OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    20 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 28/01/2019

    19 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    4 páginas600

    Endereço do domicílio registado alterado de 10 Furnival Street London EC4A 1YH para 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU em 08/03/2018

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Aviso de mudança da administração para liquidação voluntária de credores

    páginas2.34B

    Restauração por ordem judicial

    2 páginasAC92

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    3 páginas4.72

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 06/04/2012

    10 páginas4.68

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Notificação de cessação de atividade como liquidatário voluntário

    1 páginas4.40

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 06/04/2011

    13 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de * 66 Wigmore Street London W1A 3RT* em 04/03/2011

    2 páginasAD01

    Aviso de mudança da administração para liquidação voluntária de credores

    9 páginas2.34B

    Aviso de mudança da administração para liquidação voluntária de credores

    7 páginas2.34B

    Relatório de progresso do administrador até 12/11/2009

    6 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 12/11/2009

    6 páginas2.24B

    Declaração de negócios com formulário 2.14B

    15 páginas2.16B

    Declaração de proposta do administrador

    30 páginas2.17B

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed diagnosys LIMITED\certificate issued on 26/06/09
    2 páginasCERTNM

    legacy

    1 páginas287

    Nomeação de um administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    1 páginas288c

    Quem são os diretores de OLDNAME NO. 397 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GOULIMIS, Denise
    Lyford Cay Drive
    Lyford Cay
    Nassau
    Shuttlecock Cottage
    PO BOX N7776
    Bahamas
    Diretor
    Lyford Cay Drive
    Lyford Cay
    Nassau
    Shuttlecock Cottage
    PO BOX N7776
    Bahamas
    Greek133964450001
    HARRISON, John Trevor
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    Diretor
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish120531710001
    HEASMAN, Philip
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BD Guildford
    1 Chaucer House
    Surrey
    Diretor
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BD Guildford
    1 Chaucer House
    Surrey
    United KingdomAustralian63852560002
    MCINTOSH, Charles William Allistair
    Glenluce Road
    Blackheath
    SE3 7SD London
    37
    Diretor
    Glenluce Road
    Blackheath
    SE3 7SD London
    37
    British133364010001
    MCINTOSH, Ian Alexander Neville
    83 Crown Lodge
    Elystan Street
    SW3 3PR London
    Diretor
    83 Crown Lodge
    Elystan Street
    SW3 3PR London
    United KingdomBritish60901880002
    SMITH, Robert Louis
    Dragon Street
    GU31 4JJ Petersfield
    24-26
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Dragon Street
    GU31 4JJ Petersfield
    24-26
    Hampshire
    United Kingdom
    British131286830001
    WOODING, Jeremy Michael
    Maunsel Street
    Westminster
    SW1P 2QN London
    25
    Diretor
    Maunsel Street
    Westminster
    SW1P 2QN London
    25
    EnglandBritish54883990002
    CHANT, John
    Comyn
    Upper Anstey Lane
    GU34 4BP Alton
    Hampshire
    Secretário
    Comyn
    Upper Anstey Lane
    GU34 4BP Alton
    Hampshire
    British34373580001
    WAKE, Nicholas
    Downlands, Wood Lane
    Seale
    GU10 1HB Farnham
    Surrey
    Secretário
    Downlands, Wood Lane
    Seale
    GU10 1HB Farnham
    Surrey
    British42620390002
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    Secretário nomeado
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    900008790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNARD, Adam
    30 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    Diretor
    30 Burdenshott Avenue
    TW10 5ED Richmond
    Surrey
    South African65525620002
    BRIDLE, Mark Leslie
    15 Willow Way
    RH20 3BG Ashington
    West Sussex
    Diretor
    15 Willow Way
    RH20 3BG Ashington
    West Sussex
    British8862860001
    CAWKELL, David
    Ford Arun Snailing Lane
    Greatham
    GU33 6HQ Liss
    Hampshire
    Diretor
    Ford Arun Snailing Lane
    Greatham
    GU33 6HQ Liss
    Hampshire
    EnglandBritish29634190002
    LOCK, Maureen
    22 Orchard Mains
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    Diretor
    22 Orchard Mains
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    South African78409990001
    TIPLIN, David Robert
    54 Newbolt Avenue
    SM3 8EE Cheam
    Surrey
    Diretor
    54 Newbolt Avenue
    SM3 8EE Cheam
    Surrey
    EnglandBritish82007290001
    WAKE, Nicholas
    The Old Mill
    Kitts Lane
    DU10 2PJ Churt
    Surrey
    Diretor
    The Old Mill
    Kitts Lane
    DU10 2PJ Churt
    Surrey
    British42620390003
    WELLAND, Paul Stephen
    116 Stakes Road
    Purbrook
    PO7 5PW Waterlooville
    Hampshire
    Diretor
    116 Stakes Road
    Purbrook
    PO7 5PW Waterlooville
    Hampshire
    British13174060002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    OLDNAME NO. 397 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 22/08/2008
    Entregue em 28/08/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 28/08/2008Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 06/11/2003
    Entregue em 15/11/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/11/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/09/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 25/10/2002
    Entregue em 08/11/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Leasehold properties units 2 and 3 petersfield business park, bedford road, petersfield, hampshire. Unit 15 petersfield business park, bedford road, petersfield, hampshire and unit 4 viceroy court, bedford road, petersfield, hampshire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Grenadier Development Capital Fund 1 Limited Partnership Acting by Its General Partnergrenadier Capital General Partner Limited
    Transações
    • 08/11/2002Registro de uma garantia (395)
    Instrument creating secured loan stock 2005 of the company
    Criado em 25/10/2002
    Entregue em 08/11/2002
    Pendente
    Montante garantido
    By way of continuing security in favour of the stockholder for the payment and discharge of secured loabn stock 2005 constituted by the secured loan stock instrument with a principal amount of £1,000,000 plus interest and costs
    Breve descrição
    By way of a fixed charge all estate or interest in any freehold and leasehold property and any proceeds of sale now and in the future vested in the company. By way of a fixed charge all its right, title, interest and benefit present and future in and to the plant, machinery and fixtures and fittings at the property, the furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, the goodwill and uncalled capital, the book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Grenadier Development Capital Fund 1 Limited Partnership Acting by Its General Partnergrenadier Capital General Partner Limited
    Transações
    • 08/11/2002Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 30/06/1999
    Entregue em 09/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a plot e vision park petersfield hants. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/07/1999Registro de uma garantia (395)
    • 15/11/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1996
    Entregue em 05/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 05/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 29/10/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    OLDNAME NO. 397 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    13/05/2009Início da administração
    07/04/2010Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Profissional
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Nicholas H O'Reilly
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Profissional
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    2
    DataTipo
    07/04/2010Início da liquidação
    17/10/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Profissional
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Nicholas H O'Reilly
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Profissional
    Po Box 2653, 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Geoffrey Paul Rowley
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Profissional
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profissional
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profissional
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0