DAISY WHOLESALE LIMITED

DAISY WHOLESALE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDAISY WHOLESALE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02612286
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DAISY WHOLESALE LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica DAISY WHOLESALE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Lindred House, 20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DAISY WHOLESALE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DIGITAL WHOLESALE SOLUTIONS NUMBER 2 LIMITED26/04/201926/04/2019
    DIGITAL WHOLESALE SOLUTIONS LIMITED24/10/201824/10/2018
    COYO LIMITED27/07/201827/07/2018
    VHA LIMITED14/05/199114/05/1991

    Quais são as últimas contas de DAISY WHOLESALE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2020

    Quais são as últimas submissões para DAISY WHOLESALE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaração de confirmação apresentada em 14/05/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Issued share capital of the company, be subdivided 21/12/2021
    RES13

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Issued share capital of the company ,be sub divided 21/12/2021
    RES13

    Subdivisão de ações em 21/12/2021

    4 páginasSH02

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital em 29/12/2021

    • Capital: GBP 0.01
    5 páginasSH19

    Declaração de confirmação apresentada em 14/05/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2020

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/05/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2019

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/05/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Notificação de Daisy Telecoms Limited como pessoa com controlo significativo em 28/03/2019

    2 páginasPSC02

    Cessação de Daisy Computer Group Limited como pessoa com controlo significativo em 28/03/2019

    1 páginasPSC07

    Endereço do domicílio registado alterado de Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR England para Lindred House, 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR em 29/04/2019

    1 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name26/04/2019

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name26/04/2019

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Término da nomeação de Nathan Richard Marke como diretor em 01/02/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Lewis Mcglennon como secretário em 01/02/2019

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018

    6 páginasAA

    Quem são os diretores de DAISY WHOLESALE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MCGLENNON, David Lewis
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House,
    Diretor
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House,
    United KingdomBritishCompany Director181536600001
    SMITH, Stephen Alan
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House,
    Diretor
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House,
    United KingdomBritishCompany Director161471940001
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Secretário
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    BritishFinance Director113317640001
    MARTIN, William Thomas
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Secretário
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    BritishCompany Secretary57302660001
    MCGLENNON, David Lewis
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    Secretário
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    199438530001
    STOKES, Reeta
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northamptonshire
    England
    Secretário
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northamptonshire
    England
    173999830001
    TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes
    The Lakes
    Lakeside House
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    Secretário
    The Lakes
    Lakeside House
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    179712280001
    WAINWRIGHT, Stephen
    Cedar Lodge
    Molly Hurst Lane Wooley
    WF4 2JX Wakefield
    West Yorkshire
    Secretário
    Cedar Lodge
    Molly Hurst Lane Wooley
    WF4 2JX Wakefield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant13393650001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretário nomeado
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    c/o Phoenix It Group Plc
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northamptonshire
    England
    Diretor
    c/o Phoenix It Group Plc
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritishDirector294355310001
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Diretor
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director52852920002
    CLUTTON, Steven
    Oakwell Way
    Oakwell Business Park
    WF17 9LU Birstall
    Phoenix House
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    Oakwell Way
    Oakwell Business Park
    WF17 9LU Birstall
    Phoenix House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritishDirector158451560001
    COURTLEY, David John
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northants
    United Kingdom
    Diretor
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Technology House
    Northants
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector141213480001
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Diretor
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director113317640001
    GRANELLI, Anthony
    37 Woodthorpe Park Drive
    Sandal
    WF2 6SU Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    37 Woodthorpe Park Drive
    Sandal
    WF2 6SU Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector8185550001
    MARKE, Nathan Richard
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    Diretor
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishCompany Director194292450001
    MULLER, Neil Keith
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    Diretor
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    EnglandBritishCompany Director252490400001
    RILEY, Matthew Robinson
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    Diretor
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishCompany Director178585250001
    ROBERTS, Barry Arthur
    7 Tudor Lawns
    Carr Gate
    WF2 0UU Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    7 Tudor Lawns
    Carr Gate
    WF2 0UU Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director8184250002
    ROBINSON, Nicholas John
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    Diretor
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector54873290006
    ROBINSON, Nicholas
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    BritishDirector54873290005
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Diretor
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    EnglandBritishGroup Finance Director80817560001
    STAFFORD, Jeremy John
    The Old Rectory
    Lower Weald, Calverton
    MK19 6EE Milton Keynes
    Bucks
    Diretor
    The Old Rectory
    Lower Weald, Calverton
    MK19 6EE Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritishChief Operating Officer116431970001
    TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Diretor
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    EnglandBritishDirector190098560001
    WAINWRIGHT, Stephen
    'Woodlands'
    Thunderbridge Lane, Thunderbridge
    HD8 0PX Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    'Woodlands'
    Thunderbridge Lane, Thunderbridge
    HD8 0PX Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant13393650002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Diretor nomeado
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Quem são as pessoas com controle significativo de DAISY WHOLESALE LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    28/03/2019
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro6977942
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    06/04/2016
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House
    Lancashire
    England
    Sim
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro03134540
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    DAISY WHOLESALE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 20/08/2002
    Entregue em 28/08/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/08/2002Registro de uma garantia (395)
    Guarantee & debenture
    Criado em 23/07/2002
    Entregue em 31/07/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 31/07/2002Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 03/08/2001
    Entregue em 07/08/2001
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a unit BT4007/2 oakwell park industrial estate birstall west yorkshire t/no: WYK444279.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/08/2001Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 15/05/1992
    Entregue em 18/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 1A invar road industrial estate priestley road swinton manchester t/nos. Part GM526986 and part GM557346 and all fixtures fittings plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 18/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 18/04/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 31/03/1992
    Entregue em 09/04/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 2 oakwell way oakwell park birstall west yorkshire t/no.WYK444279 fixed charge over plant machinery fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 09/04/1992Registro de uma garantia (395)
    • 25/01/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 09/03/1992
    Entregue em 13/03/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank PLC
    Transações
    • 13/03/1992Registro de uma garantia (395)
    • 25/01/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0