GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED

GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02656702
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção

    Onde fica GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    TEESRAN LIMITED25/11/199125/11/1991
    BIDEAWHILE ONE HUNDRED AND THREE LIMITED23/10/199123/10/1991

    Quais são as últimas contas de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Qual é o status da última declaração anual para GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016

    1 páginasAA01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Jonathan Ross Brodie em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG para Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP em 23/10/2015

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 12/10/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/10/2015

    Estado do capital em 12/10/2015

    • Capital: GBP 31
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 1

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 7

    4 páginasMR04

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 15/12/2014

    1 páginasCH03

    Declaração anual preparada até 12/10/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital13/10/2014

    Estado do capital em 13/10/2014

    • Capital: GBP 31
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Elizabeth Catchpole como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Jon William Mortimore como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 12/10/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/10/2013

    Estado do capital em 14/10/2013

    • Capital: GBP 31
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/10/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Quem são os diretores de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secretário
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808030001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretário
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Secretário
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    BWL SECRETARIES LIMITED
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    Secretário nomeado
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    900003770001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Diretor
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    Diretor
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    EnglandBritish98235420004
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Diretor
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CAMERON, Alexander Douglas
    74 Old Barrack Road
    IP12 4ER Woodbridge
    Suffolk
    Diretor
    74 Old Barrack Road
    IP12 4ER Woodbridge
    Suffolk
    British5996730001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CLINTON, David
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30279690001
    COMER, Geoffrey Stephen
    Robin Cottage
    Mill Street
    CO6 5AD Polstead
    Suffolk
    Diretor
    Robin Cottage
    Mill Street
    CO6 5AD Polstead
    Suffolk
    British56333770001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Diretor
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Diretor
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritish207729000002
    WILSON, Peter George
    Acomb Mill
    The Ridings
    NE46 4PQ Hexham
    Northumberland
    Diretor
    Acomb Mill
    The Ridings
    NE46 4PQ Hexham
    Northumberland
    British37238690003
    BWL SECRETARIES LIMITED
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    Diretor nomeado
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    900003770001

    GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Charge
    Criado em 09/01/2009
    Entregue em 15/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £353,400.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The quadrangle lumely road horley t/no SY686086.
    Pessoas com direito
    • Freehold Managers (Nominees) Limited
    Transações
    • 15/01/2009Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 09/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 09/01/2009Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 11/10/2002
    Entregue em 15/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property situate at warwick castle park, stratford road, warwick and the hunting lodge, leafield farm, stratford road, warwick t/nos. WK256708 and WK261596. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 11/10/2002
    Entregue em 15/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property k/a land and buildings lying on the south east side of the crescent, nottingham t/no. NT244678. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 13/12/2001
    Entregue em 15/12/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings to the north east side of albert road horley t/no: SY686086. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/12/2001Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 14/07/2000
    Entregue em 27/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 27/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 27/01/1992
    Entregue em 29/01/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that the property k/as or being 1.894 acres of land at ransomes europark,nacton road,ipswich,suffolk.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/01/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 23/01/1992
    Entregue em 29/01/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Please see M127C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/01/1992Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0