L & H DEVELOPMENTS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | L & H DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02662561 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
- desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
Onde fica L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| LONDON AND HENLEY LIMITED | 17/03/1993 | 17/03/1993 |
| LONDON AND HENLEY INVESTMENTS LIMITED | 23/06/1992 | 23/06/1992 |
| TARGETRAISE LIMITED | 13/11/1991 | 13/11/1991 |
Quais são as últimas contas de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2018 |
Quais são as últimas submissões para L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||
Satisfação total da garantia 6 | 4 páginas | MR04 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 13/11/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de Timothy Andrew Roberts como diretor em 25/04/2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Sarah Morrell Barzycki como diretor em 30/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Nigel Mark Webb como diretor em 25/04/2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mr Charles John Middleton como diretor em 25/04/2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr Bruce Michael James como diretor em 25/04/2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr Jonathan Charles Mcnuff como diretor em 25/04/2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018 | 4 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Lucinda Margaret Bell como diretor em 19/01/2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 13/11/2017 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Nigel Mark Webb em 25/05/2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mrs Lucinda Margaret Bell em 25/05/2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mrs Sarah Morrell Barzycki em 25/05/2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2017 | 3 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Christopher Michael John Forshaw como diretor em 05/04/2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Christopher Michael John Forshaw como diretor em 05/04/2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Christopher Michael John Forshaw como diretor em 05/04/2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Ndiana Ekpo como secretário em 06/12/2016 | 1 páginas | TM02 | ||
Nomeação de British Land Company Secretarial Limited como secretário em 06/12/2016 | 2 páginas | AP04 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 13/11/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2016 | 4 páginas | AA | ||
Quem são os diretores de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretário | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Diretor | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Diretor | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Secretário | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| BURGESS, Graeme | Secretário | Bali Hai Cudham Lane North TN14 7RB Sevenoaks Kent | British | 102349020001 | ||||||||||
| CADER, Tariq Azad | Secretário | 19 Brookview Road Streatham SW16 6UA London | British | 42841550001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretário | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| KEARTON GEE, Frank Watts | Secretário | The Windrush Stoke Row Road RG9 5JD Peppard Common Oxfordshire | British | 16914130001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretário | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Diretor | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| CADER, Tariq Azad | Diretor | 19 Brookview Road Streatham SW16 6UA London | British | 42841550001 | ||||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Diretor | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Diretor | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
| COOK, Kevin William | Diretor | Oakcroft Redlands Lane Ewshot GU10 5AS Farnham Surrey | British | 16914120001 | ||||||||||
| ECCLES, Christopher John | Diretor | 7 Grovenor Road Chiswick W41 3EJ London | British | 61037210002 | ||||||||||
| ECCLES, Christopher John | Diretor | Salcombe Regis House Salcombe Regis EX10 0JH Sidmouth Devon | Great Britain | British | 61037210003 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Diretor | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GUNSTON, Michael Ian | Diretor | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||||||
| HAMILTON, Laura Louise | Diretor | 5 Park Lodge Park Close SW1X 7PH London | American | 73545680001 | ||||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Diretor | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Diretor | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| KEARTON GEE, Frank Watts | Diretor | The Windrush Stoke Row Road RG9 5JD Peppard Common Oxfordshire | England | British | 16914130001 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Diretor | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Albert Richard Jr | Diretor | 5 Relton Mews SW7 1ET London | Usa | 73545620001 | ||||||||||
| RITBLAT, John, Sir | Diretor | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | 41694870001 | |||||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Diretor | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Diretor | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Diretor | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Henley Limited | 06/04/2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
| |||||||
L & H DEVELOPMENTS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 21/12/2000 Entregue em 05/01/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies and liabilities due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any current or other account whatever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge debenture | Criado em 19/07/2000 Entregue em 27/07/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction | |
Breve descrição By way of floating charge all the assets undertaking and property. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Criado em 18/12/1997 Entregue em 24/12/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Floating charge over the undertaking and all its property and assets present and future. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 27/06/1997 Entregue em 16/07/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Criado em 26/07/1995 Entregue em 05/08/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the deed | |
Breve descrição Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 26/07/1995 Entregue em 28/07/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0