L & H DEVELOPMENTS LIMITED

L & H DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaL & H DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02662561
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção

    Onde fica L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LONDON AND HENLEY LIMITED17/03/199317/03/1993
    LONDON AND HENLEY INVESTMENTS LIMITED23/06/199223/06/1992
    TARGETRAISE LIMITED13/11/199113/11/1991

    Quais são as últimas contas de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2018

    Quais são as últimas submissões para L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Satisfação total da garantia 6

    4 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 13/11/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Término da nomeação de Timothy Andrew Roberts como diretor em 25/04/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Sarah Morrell Barzycki como diretor em 30/03/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Nigel Mark Webb como diretor em 25/04/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Charles John Middleton como diretor em 25/04/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Bruce Michael James como diretor em 25/04/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Jonathan Charles Mcnuff como diretor em 25/04/2018

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018

    4 páginasAA

    Término da nomeação de Lucinda Margaret Bell como diretor em 19/01/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 13/11/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Nigel Mark Webb em 25/05/2017

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mrs Lucinda Margaret Bell em 25/05/2017

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mrs Sarah Morrell Barzycki em 25/05/2017

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2017

    3 páginasAA

    Término da nomeação de Christopher Michael John Forshaw como diretor em 05/04/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Christopher Michael John Forshaw como diretor em 05/04/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Christopher Michael John Forshaw como diretor em 05/04/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Ndiana Ekpo como secretário em 06/12/2016

    1 páginasTM02

    Nomeação de British Land Company Secretarial Limited como secretário em 06/12/2016

    2 páginasAP04

    Declaração de confirmação apresentada em 13/11/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2016

    4 páginasAA

    Quem são os diretores de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretário
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Diretor
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Diretor
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Diretor
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secretário
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    BURGESS, Graeme
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    Secretário
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    British102349020001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Secretário
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Secretário
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    British16914130001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Diretor
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Diretor
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Diretor
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Diretor
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Diretor
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Diretor
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Diretor
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    COOK, Kevin William
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    Diretor
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    British16914120001
    ECCLES, Christopher John
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    Diretor
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    British61037210002
    ECCLES, Christopher John
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Diretor
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Great BritainBritish61037210003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Diretor
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Diretor
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Diretor
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HAMILTON, Laura Louise
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    Diretor
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    American73545680001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Diretor
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Diretor
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Diretor
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    EnglandBritish16914130001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Diretor
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MOORE, Albert Richard Jr
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Diretor
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Usa73545620001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Diretor
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Diretor
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Diretor
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Diretor
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritish63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Diretor
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001

    Quem são as pessoas com controle significativo de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    London And Henley Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06/04/2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    L & H DEVELOPMENTS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 21/12/2000
    Entregue em 05/01/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies and liabilities due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any current or other account whatever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 05/01/2001Registro de uma garantia (395)
    • 02/02/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge debenture
    Criado em 19/07/2000
    Entregue em 27/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction
    Breve descrição
    By way of floating charge all the assets undertaking and property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 27/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 09/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 18/12/1997
    Entregue em 24/12/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Floating charge over the undertaking and all its property and assets present and future.
    Pessoas com direito
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedas Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transações
    • 24/12/1997Registro de uma garantia (395)
    • 14/09/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Floating charge
    Criado em 27/06/1997
    Entregue em 16/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 09/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 26/07/1995
    Entregue em 05/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the deed
    Breve descrição
    Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedies as Defined Therein ("the Security Trustee")(As Security Trustee for the Security Beneficiar
    Transações
    • 05/08/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 05/08/1995Registro de uma garantia (395)
    Floating charge
    Criado em 26/07/1995
    Entregue em 28/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0