AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED

AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaAVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02666866
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Onde fica AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o CLB COPPERS
    Century House
    11 St. Peters Square
    M2 3DN Manchester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NOVASIDE LIMITED24/09/199924/09/1999
    AVONSIDE GROUP LIMITED05/02/199205/02/1992
    CSI BUILDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY28/11/199128/11/1991

    Quais são as últimas contas de AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2008

    Quais são as últimas submissões para AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    3 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de Churchill House Regent Road Stoke on Trent Staffordshire ST1 3RQ em 13/01/2010

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Denise Walker como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 18/12/2009

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 02/11/2009 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/11/2009

    Estado do capital em 03/11/2009

    • Capital: GBP 10,175,447
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Denise Margaret Walker em 02/11/2009

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2008

    14 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 31/12/2007

    17 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2006

    7 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2005

    7 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas anuais preparadas até 31/12/2004

    16 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas anuais preparadas até 31/12/2003

    18 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    6 páginas363s

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas403a

    Quem são os diretores de AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TALLO, John Lambie
    41 Gleneagles Drive
    Penwortham
    PR1 0JT Preston
    Secretário
    41 Gleneagles Drive
    Penwortham
    PR1 0JT Preston
    British634410003
    WALKER, Jonathan James
    Haberfield Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    Diretor
    Haberfield Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    EnglandBritish39444010001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Secretário
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    RIMMER, David Norman
    Ridgefield
    23 Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Staffordshire
    Secretário
    Ridgefield
    23 Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Staffordshire
    British71617270002
    SLATER, Richard Craig Alan
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    Secretário
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    British37111560003
    STEWART, Alan James
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    Secretário
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    British49964620002
    WILD, Pamela Jayne
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    Secretário
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    British64167100001
    BALL, John Alexander
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish1011280002
    BURKE, Anthony
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    Diretor
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    British58500120001
    CARRUTH, Gordon William
    90 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    Diretor
    90 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    British403770001
    DICKINSON, Ronald William
    57 Redland Drive
    HU10 7UX Kirkella
    North Humberside
    Diretor
    57 Redland Drive
    HU10 7UX Kirkella
    North Humberside
    British25252540005
    GLYNN, Christopher
    Cliffordine House
    Selsley
    GL5 5LB Stroud
    Gloucestershire
    Diretor
    Cliffordine House
    Selsley
    GL5 5LB Stroud
    Gloucestershire
    British18296920001
    GRAY, Colin Francis
    29 Holmdene Avenue
    SE24 9LB London
    Diretor
    29 Holmdene Avenue
    SE24 9LB London
    British17566780001
    HUMPHREY, David Trevor
    29 Cedar Grove
    LA9 5BL Kendal
    Cumbria
    Diretor
    29 Cedar Grove
    LA9 5BL Kendal
    Cumbria
    British48367960002
    LEE, David
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    Diretor
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    British77825310004
    MACK, Christopher Charles Robert
    18 Oakley Park
    BL1 5XL Bolton
    Lancashire
    Diretor
    18 Oakley Park
    BL1 5XL Bolton
    Lancashire
    British158640001
    MURRAY, Stephen
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    Diretor
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish90170480001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Diretor
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    PALIN, Robert Hornby
    Parkholm Springfield Park
    Overton On Dee
    LL13 0EX Wrexham
    Clwyd
    Wales
    Diretor
    Parkholm Springfield Park
    Overton On Dee
    LL13 0EX Wrexham
    Clwyd
    Wales
    British46962730001
    PHILLIPS, Ronald Luther Desmond
    Pembroke House
    71 B The Common
    WN8 7EA Parbold
    Lancashire
    Diretor
    Pembroke House
    71 B The Common
    WN8 7EA Parbold
    Lancashire
    British10631600003
    SAYERS, Steven
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    Diretor
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    United KingdomBritish91113050001
    SCOWCROFT, Brian
    1 Northwold Drive
    BL1 5BH Bolton
    Lancashire
    Diretor
    1 Northwold Drive
    BL1 5BH Bolton
    Lancashire
    British16196010001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    Diretor
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    British37111560003
    STEWART, Alan James
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    Diretor
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish49964620002
    TALBOT RICE, Nicholas Charles
    Pigeon House
    Coln Rogers
    BL54 3LB Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Pigeon House
    Coln Rogers
    BL54 3LB Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish2830650001
    WALKER, Denise Margaret
    Haberfield
    Old Moor Road Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    Diretor
    Haberfield
    Old Moor Road Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    EnglandBritish99687220001
    WALKER, Malcolm Charles
    2 Woodside Greenacres
    Greenstiles Lane Swanland
    HU14 3NH North Ferriby
    North Humberside
    Diretor
    2 Woodside Greenacres
    Greenstiles Lane Swanland
    HU14 3NH North Ferriby
    North Humberside
    British25252520004

    AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage debenture (in respect of units 1-5 holden road industrial estate,leigh,cheshire;title numbers GM565948 and GM831938)
    Criado em 07/04/2003
    Entregue em 15/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Including units 1-5 holden road industrial estate,leigh,cheshire; t/nos GM565948 and GM831983. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 15/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 25/10/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 25/10/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/10/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed to a mortgage deed dated 4 august 1999
    Criado em 22/11/2002
    Entregue em 03/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land on the south east side of platt fold street leigh wigan greater manchester t/no: GM138559. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/10/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 04/08/1999
    Entregue em 11/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lombard Natwest Factors Limited
    Transações
    • 11/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 04/08/1999
    Entregue em 11/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 11/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 25/10/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 25/10/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/10/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 04/08/1999
    Entregue em 11/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transações
    • 11/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    05/02/2011Data de dissolução
    18/12/2009Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Mark Terence Getliffe
    Century House 11 St Peters Square
    M2 3DN Manchester
    Profissional
    Century House 11 St Peters Square
    M2 3DN Manchester
    Diane Elizabeth Hill
    Clb Coopers
    Century House
    M2 3DN 11 St Peters Square
    Manchester
    Profissional
    Clb Coopers
    Century House
    M2 3DN 11 St Peters Square
    Manchester

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0