ABSOLUTE RADIO LIMITED

ABSOLUTE RADIO LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaABSOLUTE RADIO LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02674136
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    • Radiodifusão (60100) / Informação e comunicação

    Onde fica ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    TIML RADIO LIMITED12/09/200812/09/2008
    VIRGIN RADIO LIMITED18/12/199218/12/1992
    INDEPENDENT MUSIC RADIO LIMITED 31/01/199231/01/1992
    ROCK 1215 LIMITED21/01/199221/01/1992
    MARK 2179 LIMITED24/12/199124/12/1991

    Quais são as últimas contas de ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2019

    Quais são as últimas submissões para ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 31/12/2019

    23 páginasAA

    legacy

    38 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 03/12/2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    28 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do secretário alterados para Bauer Group Secretariat Limited em 25/09/2018

    1 páginasCH04

    Detalhes do diretor alterados para Mrs Sarah Jane Vickery em 25/09/2018

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Paul Keenan em 25/09/2018

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    41 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account 13/12/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital em 14/12/2017

    • Capital: GBP 5,959,750
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Quem são os diretores de ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Secretário
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Diretor
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Diretor
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritishPublisher243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Diretor
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director119137220004
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Secretário
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    BritishChartered Management Accountan77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Secretário
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    BritishCompany Secretary51065860001
    FLYNN, Roger Patrick
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Secretário
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    BritishCommercial Director66703670003
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Secretário
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    ROBINSON, Adrian Mervyn
    6 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Clonskeagh
    Dublin 14
    Ireland
    Secretário
    6 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Clonskeagh
    Dublin 14
    Ireland
    Irish77585790001
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    Secretário
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    British118367070001
    ZAMET, Naomi Rae
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    Secretário
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    British42158970002
    ZIPRIN, Geoffrey Charles
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    Secretário nomeado
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    British900001590001
    AUMONIER, John Martin
    Little Heath Nyetimber Lane
    West Chiltington
    RH20 2ND Pulborough
    West Sussex
    Diretor
    Little Heath Nyetimber Lane
    West Chiltington
    RH20 2ND Pulborough
    West Sussex
    OtherManaging Director63227690001
    BLACKABY, Oliver Guy
    Cholmeley Crescent
    Highgate
    N6 5EX London
    47
    Diretor
    Cholmeley Crescent
    Highgate
    N6 5EX London
    47
    United KingdomBritishIndependent Consultant131001170001
    CAMPBELL, David Lachlan
    GU28
    Diretor
    GU28
    EnglandBritishCompany Director58507320001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Diretor
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritishCompany Director68747470001
    DHARIWAL, Ravindra
    Oopp Nv Farms, Khasra No 1523
    Sub Po S P School
    110030 Bhatti Mines
    Ashray Farms
    Asola Village New Delhi
    India
    Diretor
    Oopp Nv Farms, Khasra No 1523
    Sub Po S P School
    110030 Bhatti Mines
    Ashray Farms
    Asola Village New Delhi
    India
    IndiaIndianCompany Executive137478960001
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Diretor
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritishDirector61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishChief Executive42787120004
    FLYNN, Roger Patrick
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Diretor
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    United KingdomBritishCommercial Director66703670003
    GYNGELL, Bruce
    57 Oakley Street
    SW3 5HB London
    Diretor
    57 Oakley Street
    SW3 5HB London
    AustralianCompany Director25950350001
    HAZLITT, Frances
    73 Finlay Street
    SW6 6HF London
    Diretor
    73 Finlay Street
    SW6 6HF London
    BritishCompany Director110554850001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Diretor
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritishAccountant72256160002
    HUNTINGFORD, Richard Norman Legh
    11 Baronsmead Road
    Barnes
    SW13 9RR London
    Diretor
    11 Baronsmead Road
    Barnes
    SW13 9RR London
    United KingdomBritishCompany Director3297910006
    IBBETT, Kenneth Richard Andre
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    Diretor
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    United KingdomBritishDirector34929900001
    JACKSON, Paul
    Geeta
    London Road
    SL5 9RY Sunningdale
    Berkshire
    Diretor
    Geeta
    London Road
    SL5 9RY Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Director117927650001
    LEVISON, Charles John Cuthbertson
    40 Kensington Park Gardens
    W11 2QT London
    Diretor
    40 Kensington Park Gardens
    W11 2QT London
    BritishCompany Director76794220002
    MANFREY, Barbara Louise
    55 Palace Gardens Terrace
    W8 4RU London
    Diretor
    55 Palace Gardens Terrace
    W8 4RU London
    AmericanDirector Of Venture Capital Fi34084460002
    MOLLETT, Andrew
    4 White Heron Mews
    Park Lane
    TW11 0JQ Teddington
    Middlesex
    Diretor
    4 White Heron Mews
    Park Lane
    TW11 0JQ Teddington
    Middlesex
    BritishFinance Director47101600001
    PARIGI, Amba Preetham
    10th Floor, Flat 102, A Wing
    66 Napean Sea Road
    400 036 Mumbai
    Petit Hall Tahnee Heights Chsl
    Mumbai
    India
    Diretor
    10th Floor, Flat 102, A Wing
    66 Napean Sea Road
    400 036 Mumbai
    Petit Hall Tahnee Heights Chsl
    Mumbai
    India
    IndiaIndianCompany Director134398470002
    PEARSON, Anthony John
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    Diretor
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    UkBritishChief Executive Radio44001900002
    PEARSON, Anthony John
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    Diretor
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    UkBritishDirector44001900002
    PHIPPEN, Peter Sangster
    Templewood Lane
    Stoke Poges
    SL2 4BG Slough
    "Oak Acre"
    England
    Diretor
    Templewood Lane
    Stoke Poges
    SL2 4BG Slough
    "Oak Acre"
    England
    EnglandBritishDirector32688550001
    POTTER, Irene
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    Diretor nomeado
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    British900001600001
    SHAH, Sanjeev
    Next To Maulya Centre, Senapati Bapat Marg,
    Lower Parel
    400 013 Mumbai
    A/203 2nd Floor Casea Grande Tower
    India
    Diretor
    Next To Maulya Centre, Senapati Bapat Marg,
    Lower Parel
    400 013 Mumbai
    A/203 2nd Floor Casea Grande Tower
    India
    IndiaIndianCompany Director148788520001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Bauer Ar Holdings Limited
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06/04/2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroComapnies House
    Número de registro03359692
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    ABSOLUTE RADIO LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Corporate loan agreement
    Criado em 14/12/2009
    Entregue em 23/12/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The assets, both moveable and immoveable see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Timl Global Limited
    Transações
    • 23/12/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 07/08/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Supplemental security agreement
    Criado em 16/02/2004
    Entregue em 03/03/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The trademarks and design rights specified next to its name in schedule 2 of the agreement under the heading specific intellectual property rights; any copyright or other intellectual property monopoly right in any of the above; or any interest (including by way of licence) in any of the above. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/03/2004Registro de uma garantia (395)
    • 25/11/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement
    Criado em 04/04/2003
    Entregue em 16/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent on Trust for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 16/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 25/11/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement
    Criado em 18/07/2002
    Entregue em 24/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 24/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 10/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Hedging debenture
    Criado em 30/04/1998
    Entregue em 18/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each of the obligors (as defined) to banque paribas (as security trustee for itself and the hedge provider) and to the hedge provider under the hedging documents together with all costs,charges and expenses incurred by the hedge provder and/or the security trustee in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the hedging documents
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Banque Paribas
    Transações
    • 18/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 08/12/1997
    Entregue em 24/12/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each of the obligors to the secured creditors(or any of them) under each of the senior facility documents
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Banque Paribas(As Security Trustee)
    Transações
    • 24/12/1997Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 20/03/1997
    Entregue em 27/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the facility documents and/or this debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over land (as defined) broadcasting licences all rights of the company uner or in respect of the broadcasting licences. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bankers Trust Company as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transações
    • 27/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 30/12/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 06/01/1995
    Entregue em 13/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 23/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    An issue of secured debentures in a series
    Criado em 13/12/1993
    Entregue em 23/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 23/12/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A registered charge
    Criado em 31/08/1993
    Entregue em 02/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 02/09/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A registered charge
    Criado em 24/08/1993
    Entregue em 02/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 02/09/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A registered charge
    Criado em 05/07/1993
    Entregue em 23/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Pessoas com direito
    • Not Known.
    Transações
    • 23/07/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A registered charge
    Criado em 28/06/1993
    Entregue em 29/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 29/06/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Issue of secured debentures
    Criado em 21/06/1993
    Entregue em 25/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 25/06/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Series of debentures
    Criado em 21/05/1993
    Entregue em 01/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Pessoas com direito
    • None
    Transações
    • 01/06/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Issue
    Criado em 23/04/1993
    Entregue em 10/05/1993
    Totalmente satisfeita
    Pessoas com direito
    • None
    Transações
    • 10/05/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Series of debentures
    Criado em 08/03/1993
    Entregue em 12/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Pessoas com direito
    • Virgin Communications Limited
    Transações
    • 12/03/1993Registro de uma emissão de debêntures garantidas em uma série (397a)
    • 03/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Series of debentures
    Criado em 08/03/1993
    Entregue em 12/03/1993
    Data do instrumento de cobertura 08/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Pessoas com direito
    • Virgin Communications Limited
    Transações
    • 12/03/1993Registro de um encargo para garantir uma série de debêntures (397)
    • 09/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Criado em 19/01/1993
    Entregue em 27/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Forsecuring £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Pursuant to clause 2 (f) of the deed of rent deposit referred to virgin radio limited agreed to charge £50,000 to trafalgar house developments limited as security for the performance of its obligation in a lease dated 19/1/93 relating to the 2ND 3RD and 4TH floors 1 golden square london W1 and performance of its obligation in the rent deposit deed of the aforesaid date.
    Pessoas com direito
    • Trafalgar House Developments Limited
    Transações
    • 27/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0