TELESHOP SERVICES LIMITED

TELESHOP SERVICES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTELESHOP SERVICES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02677693
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    • Comércio grossista não especializado de alimentos, bebidas e tabaco (46390) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

    Onde fica TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    FINISHGOOD LIMITED15/01/199215/01/1992

    Quais são as últimas contas de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até27/12/2014

    Qual é o status da última declaração anual para TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Resoluções

    Resolutions
    21 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 15/12/2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Share premium account cancelled. Sum of £450,056 be credited to the p/l 07/12/2015
    RES13

    Satisfação total da garantia 2

    4 páginasMR04

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 1

    5 páginasMR05

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Término da nomeação de Christopher Nicholas Martin como diretor em 14/09/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Timothy Kenny como diretor em 14/09/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Thomas Codd como diretor em 14/09/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Thomas Codd como secretário em 14/09/2015

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Jonathan Paul Prentis como diretor em 14/09/2015

    2 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS para Equity House Irthlingborough Road Wellingborough Northamptonshire NN8 1LT em 29/09/2015

    1 páginasAD01

    Renúncia de um auditor

    3 páginasAA03

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 27/12/2014

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/01/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/01/2015

    Estado do capital em 15/01/2015

    • Capital: GBP 447,187
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    11 páginasAA

    Término da nomeação de Donal Horgan como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 15/01/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/01/2014

    Estado do capital em 16/01/2014

    • Capital: GBP 447,187
    SH01

    Quem são os diretores de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Diretor
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish177693990001
    CLAYTON, Ian David Keith
    11 The Court
    Marine Gate Promenade
    PR9 0EG Southport
    Secretário
    11 The Court
    Marine Gate Promenade
    PR9 0EG Southport
    British18285200002
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Secretário
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    182404910001
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretário
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish108011300001
    HARE, Richard Warren
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    Secretário
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    British2955620006
    MORGAN, David George
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    Secretário
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    British16133400001
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Secretário
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Irish123363960001
    TREBBLE, Christopher John
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    Secretário
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    British51754910001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Secretário
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    British114305580001
    BARNETT, Louise Annabel
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Diretor
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British54609000001
    BARNETT, Louise Annabel
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Diretor
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British54609000001
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Diretor
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish182392430001
    DAVIES, Colin Ernest
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    Diretor
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78759470002
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish108011300001
    ELLIS, Peter Brian
    11 Hanover Close St Botolphs View
    Barton Seagrave
    NN15 6GH Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    11 Hanover Close St Botolphs View
    Barton Seagrave
    NN15 6GH Kettering
    Northamptonshire
    British45029930001
    HORGAN, Donal Patrick
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Diretor
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrish163398920001
    HYSON, Martin John
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    Diretor
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    United KingdomBritish128460840001
    KENNY, Timothy, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Diretor
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish113651250001
    MARTIN, Christopher Nicholas
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Diretor
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish48484090003
    MORGAN, David George
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    British16133400001
    O'FLYNN, David, Mr.
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Diretor
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrish163739400001
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Diretor
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Irish123363960001
    OLD, Douglas Henry
    Clevedale
    Green Lane, Collingham
    LS22 5DE Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    Clevedale
    Green Lane, Collingham
    LS22 5DE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish78026400001
    PYE, James Francis
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    Diretor
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    British99123350001
    PYPER, Simon John
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    Diretor
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    British108173190001
    RIGBY, Graham Lakin
    Magnolia Cottage 4 Fulmer Place Farm
    SL3 6HP Fulmer
    Buckinghamshire
    Diretor
    Magnolia Cottage 4 Fulmer Place Farm
    SL3 6HP Fulmer
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74211400002
    SMITH, Philip Anthony
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Diretor
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish233299960001
    TAYLOR, Michael John
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish122666080001
    TREBBLE, Christopher John
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    Diretor
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    British51754910001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Diretor
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish114305580002

    TELESHOP SERVICES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 25/01/1998
    Entregue em 02/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts; by way of first floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future including the assets comprised in the fixed charges to the extent that such fixed assets shall for any reason be ineffective.
    Pessoas com direito
    • Euro Sales Finance PLC
    Transações
    • 02/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 05/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 02/08/1994
    Entregue em 05/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 05/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 05/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 31/03/1993
    Entregue em 09/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 31ST march 1993
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lancashire Enterprises Venture Fund
    Transações
    • 09/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 10/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 31/03/1993
    Entregue em 06/04/1993
    Pendente
    Montante garantido
    The performance of the tenant's obligations under the lease of even date and this deed to the chargee
    Breve descrição
    £15,000.00 placed in a separate account with the landlord'sbankers.
    Pessoas com direito
    • Commission for the New Towns
    Transações
    • 06/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 10/12/2015Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0