THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED

THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02681703
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED?

    • (7499) /

    Onde fica THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    3rd Floor Network House
    Basing View
    RG21 4HG Basingstoke
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BRITISH GAS LEASING CAPITAL LIMITED18/05/199318/05/1993
    BRITISH GAS LEASING NO. 4 LIMITED12/02/199212/02/1992
    VASMIR LIMITED28/01/199228/01/1992

    Quais são as últimas contas de THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 19/09/2011

    • Capital: GBP 250
    5 páginasSH19

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Término da nomeação de Michael Pelham Morris Olive como diretor em 09/09/2011

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2010

    2 páginasAA

    Declaração anual preparada até 26/01/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Endereço do domicílio registado alterado de Brook Henderson House 37-43 Blagrave Street Reading Berkshire RG1 1PZ em 23/08/2010

    2 páginasAD01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/03/2010 para 30/09/2010

    1 páginasAA01

    Declaração anual preparada até 26/01/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Michael Pelham Morris Olive em 30/11/2009

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2009

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Contas preparadas até 31/03/2008

    7 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    Contas preparadas até 31/03/2007

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    2 páginas363a

    Contas preparadas até 31/03/2006

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    2 páginas363a

    Contas preparadas até 31/03/2005

    6 páginasAA

    Quem são os diretores de THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Secretário
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    BritishCompany Executive45962560004
    EDDY, Jonathan Charles Grenville
    18 Fitzroy Road
    GU51 4JJ Fleet
    Hampshire
    Diretor
    18 Fitzroy Road
    GU51 4JJ Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector72062400004
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Diretor
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    United KingdomBritishCompany Executive45962560004
    EVES, Richard Anthony
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    Secretário
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    British51097960001
    GARRIHY, Anne
    38 Bunbury Way
    KT17 4JP Epsom
    Surrey
    Secretário
    38 Bunbury Way
    KT17 4JP Epsom
    Surrey
    BritishChartered Secretary41928680001
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Secretário
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Secretário
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    JONES, Maria Bernadette
    1 Scriveners Close
    Hillfield Road
    HP2 4AA Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretário
    1 Scriveners Close
    Hillfield Road
    HP2 4AA Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British37272130001
    MARKHAM, Una
    18 Howard Road
    RG40 2BX Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    18 Howard Road
    RG40 2BX Wokingham
    Berkshire
    BritishChartered Secretary49024710001
    POOLE, Andrew Philip
    Flat 28 2 Lansdowne Drive
    E8 3EZ London
    Secretário
    Flat 28 2 Lansdowne Drive
    E8 3EZ London
    British90354630001
    SMITH, Marie
    10 Hatch Place
    KT2 5NB Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    10 Hatch Place
    KT2 5NB Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishChartered Secretary40935980001
    THOMAS, Luke
    94 Watcombe Road
    South Norwood
    SE25 4UZ London
    Secretário
    94 Watcombe Road
    South Norwood
    SE25 4UZ London
    British48375440001
    ASWANI, Geoffrey
    62 Upper Pillory Down
    SM5 4BJ Carshalton
    Surrey
    Diretor
    62 Upper Pillory Down
    SM5 4BJ Carshalton
    Surrey
    EnglandBritishLeasing Manager94351320001
    BROWN, Robert James
    6 Waterfield
    The Moat
    TN2 5XH Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    6 Waterfield
    The Moat
    TN2 5XH Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishHead Of Power Generation (International)51105560001
    CHAN, Choong Fai
    53 Graemesdyke Avenue
    SW14 7BH London
    Diretor
    53 Graemesdyke Avenue
    SW14 7BH London
    BritishTax Manager56891690001
    CHAN, Choong Fai
    53 Graemesdyke Avenue
    SW14 7BH London
    Diretor
    53 Graemesdyke Avenue
    SW14 7BH London
    BritishFinance Director56891690001
    CHARLESWORTH, Glyn, Dr
    The Chestnuts
    Little London Road
    RG7 2PR Silchester
    Hampshire
    Diretor
    The Chestnuts
    Little London Road
    RG7 2PR Silchester
    Hampshire
    BritishDirector Corporate Strategy59795050001
    COWLEY, Craig John
    27 Regent Court
    RG1 7HW Reading
    Berkshire
    Diretor
    27 Regent Court
    RG1 7HW Reading
    Berkshire
    BritishAccountant36551350003
    FEAKIN, Philip
    4 Oakview Gardens
    East Finchley
    N2 0NJ London
    Diretor
    4 Oakview Gardens
    East Finchley
    N2 0NJ London
    BritishAssistant Group Treasurer13907400001
    FEW, Raymond James
    30 Badgers
    Thorley Park
    CM23 4ES Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Diretor
    30 Badgers
    Thorley Park
    CM23 4ES Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishPurchasing Man46881020001
    GRAY, John Charles Roger
    65 Cumberland Street
    SW1V 4LY London
    Diretor
    65 Cumberland Street
    SW1V 4LY London
    British51822330001
    HATTON, David Frederick
    33 Goldenacres
    Springfield
    CM1 5YT Chelmsford
    Essex
    Diretor
    33 Goldenacres
    Springfield
    CM1 5YT Chelmsford
    Essex
    BritishDirector Of Taxation14442710001
    HOEXTER, Nicholas Paul Batley
    142 Ifield Road
    SW10 9AF London
    Diretor
    142 Ifield Road
    SW10 9AF London
    EnglandBritishCompany Director9117220001
    HOGAN, James Michael
    17 The Orchards
    LU6 2DD Eaton Bray
    Bedfordshire
    Diretor
    17 The Orchards
    LU6 2DD Eaton Bray
    Bedfordshire
    BritishBusiness Development Director51892750001
    MELVIN, Thomas Michael
    Bockmer Hill House
    Bockmer
    SL7 2HL Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    Bockmer Hill House
    Bockmer
    SL7 2HL Marlow
    Buckinghamshire
    BritishGroup Director Of Taxation87118290001
    MOORE, Neil
    8 Saint Bernards Road
    Olton
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Diretor
    8 Saint Bernards Road
    Olton
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director67179730003
    OLIVE, Michael Pelham Morris, Mr.
    Basing View
    RG21 4HG Basingstoke
    3rd Floor Network House
    Hampshire
    Diretor
    Basing View
    RG21 4HG Basingstoke
    3rd Floor Network House
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Executive36404130004
    REID, Malcolm Gwilym
    13 Meadowside
    KT12 3LS Walton On Thames
    Surrey
    Diretor
    13 Meadowside
    KT12 3LS Walton On Thames
    Surrey
    BritishDirector Of Commercial Service46880640001
    SHOESMITH, Colin Michael
    2 Greenacres Drive
    OX12 9NR Wantage
    Oxfordshire
    Diretor
    2 Greenacres Drive
    OX12 9NR Wantage
    Oxfordshire
    BritishAccountant52283560001

    THE LEASING GROUP (SEPTEMBER) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Certificate of assignment
    Criado em 31/03/2005
    Entregue em 14/04/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All of the right title and interest of the company under the transco documents.
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transações
    • 14/04/2005Registro de uma garantia (395)
    Master charge agreement
    Criado em 29/07/2004
    Entregue em 07/08/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each of the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge, the charged equipment, all insurance monies in repect of the charged equipment, all right title and interest in respect of the customer agreements, floating charge all the charged equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transações
    • 07/08/2004Registro de uma garantia (395)
    Floating charge
    Criado em 19/10/1995
    Entregue em 01/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of floating charge all undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • British Gas PLC
    Transações
    • 01/11/1995Registro de uma garantia (395)
    • 21/01/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0