GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02762842
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção

    Onde fica GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    KEEPEAGER LIMITED09/11/199209/11/1992

    Quais são as últimas contas de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Qual é o status da última declaração anual para GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016

    1 páginasAA01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG para Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP em 23/10/2015

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 18/10/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/10/2015

    Estado do capital em 23/10/2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 2

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 10

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 11

    4 páginasMR04

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 15/12/2014

    1 páginasCH03

    Declaração anual preparada até 18/10/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/10/2014

    Estado do capital em 20/10/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Elizabeth Catchpole como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Jon William Mortimore como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 18/10/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/10/2013

    Estado do capital em 18/10/2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    9 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    Declaração anual preparada até 18/10/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Quem são os diretores de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secretário
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147807760001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretário
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Secretário
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, David Charles
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    Diretor
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    British35117370001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Diretor
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    Diretor
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    EnglandBritish98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Diretor
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Diretor
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MARSHALL, Louis Daniel
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    Diretor
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    United KingdomBritish152847400001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritish207729000002
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    Diretor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    British27564990001
    PEDLEY, Mark Jonathan
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    British112119110001
    WEST, William Samuel
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    Diretor
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    British35383900001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 09/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 09/01/2009Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 14/07/2000
    Entregue em 27/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 27/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 18/12/1998
    Entregue em 23/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Property k/a pymore bridport in the county of dorset t/n DT202773, DT207080, DT229615 & DT207062. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 23/12/1998Registro de uma garantia (395)
    • 10/11/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    First party commercial legal charge
    Criado em 17/09/1996
    Entregue em 20/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H little hamonds farm london road burgess hill east sussex t/no SX116439 fixed charge all buildings and other structures fixed charge asigns of goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 20/09/1996Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 03/11/1995
    Entregue em 08/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a moorfields mill lane south holmwood surrey t/n SY599533, allbuildings structures items plant and machinery, goodwill, rentals claims under insurance policies relating or fixed to the property, floating charge over unattached plant machinery chattels and goods in connection with the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 08/11/1995Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Assignment of life policy
    Criado em 26/09/1995
    Entregue em 11/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Lloyd's life policy no 551/N3AA079 together with all rights, title, interests and accreations thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 07/09/1995
    Entregue em 20/09/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    58 maywater close sanderstead surrey t/no: TGL304052. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 20/09/1995Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 18/08/1995
    Entregue em 29/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land k/a 5 and 5A hawthorne place and 9 linden place epsom surrey t/n's SY643611,SY364122 and SY80306. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Life policy assignation
    Criado em 20/05/1994
    Entregue em 02/06/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Lloyds underwriters :cygnet life policy no.:risk no.N3AAO79 together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 02/06/1994Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 30/11/1993
    Entregue em 07/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 30/11/1993
    Entregue em 07/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a santa tecla stanstead caterham surrey t/n SY399840. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0