HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED

HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02779675
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    REDONDA LIMITED14/01/199314/01/1993

    Quais são as últimas contas de HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2012

    Quais são as últimas submissões para HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    14 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 21/09/2015

    12 páginas4.68

    Término da nomeação de Paul Andrew Cullingford como diretor em 30/06/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Iain Alexander Speak como diretor em 31/12/2014

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 105 Duke Street Liverpool Merseyside L1 5JQ para Pannell House 159 Charles Street Leicester LE1 1LD em 07/10/2014

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resolução de insolvência

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 22/09/2014

    LRESSP

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Declaração anual preparada até 04/05/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital27/05/2014

    Estado do capital em 27/05/2014

    • Capital: GBP 2,275,000
    SH01

    Satisfação total da garantia 6

    3 páginasMR04

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 04/05/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 04/05/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    4 páginasAA

    legacy

    8 páginasMG01

    Declaração anual preparada até 04/05/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 04/05/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Iain Alexander Speak em 01/05/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Paul Andrew Cullingford em 01/01/2010

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Quem são os diretores de HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BIBBY BROS. & CO. (MANAGEMENT) LIMITED
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    Secretário
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    153567030002
    MEAR, Donald Robert
    Long Acre Hookwood Park
    Limpsfield
    RH8 0SQ Oxted
    Surrey
    Secretário
    Long Acre Hookwood Park
    Limpsfield
    RH8 0SQ Oxted
    Surrey
    BritishChartered Accountant3911520002
    SMITH, Philip Michael Forster
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    Secretário
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant35806430001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Secretário nomeado
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    BARNES, Graham Leslie
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    Diretor
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    UkBritishCompany Director14145910002
    COUCHMAN, Ivan Melvin
    South Court 88 Putnoe Lane
    MK41 9AG Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    South Court 88 Putnoe Lane
    MK41 9AG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishManaging Director901840001
    CULLINGFORD, Paul Andrew
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    Diretor
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    WalesBritishChartered Accountant53644130003
    CUTLER, John Edward
    The White House
    8 Moor Hall Drive Four Oaks
    B75 6LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    The White House
    8 Moor Hall Drive Four Oaks
    B75 6LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director126241800001
    DAVIES, John Leslie
    Elm House Effingham Road
    Copthorne
    RH10 3HZ Crawley
    West Sussex
    Diretor
    Elm House Effingham Road
    Copthorne
    RH10 3HZ Crawley
    West Sussex
    BritishCompany Director32122000001
    DE PENCIER, Theodore Henry John
    Aysgarth House 9 Moreton Avenue
    AL5 2EU Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    Aysgarth House 9 Moreton Avenue
    AL5 2EU Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director45068720001
    FARRANT, John
    Woodriding
    Woodriding, Sheethanger Lane, Felden
    HP3 0BG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Diretor
    Woodriding
    Woodriding, Sheethanger Lane, Felden
    HP3 0BG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector42955520002
    FENN, Andrew Robert
    27 Hatherden Drive
    Walmley
    B76 2RB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    27 Hatherden Drive
    Walmley
    B76 2RB Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishOperations56715000002
    JACKSON, Matthew John
    45 Merlin Way
    RH19 3XG East Grinstead
    West Sussex
    Diretor
    45 Merlin Way
    RH19 3XG East Grinstead
    West Sussex
    BritishLogistics82679490001
    LOCKHART, James
    27 Beech Hill Avenue
    Hadley Wood
    EN4 0LN Barnet
    Hertfordshire
    Diretor
    27 Beech Hill Avenue
    Hadley Wood
    EN4 0LN Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director39016590001
    MEAR, Donald Robert
    Long Acre Hookwood Park
    Limpsfield
    RH8 0SQ Oxted
    Surrey
    Diretor
    Long Acre Hookwood Park
    Limpsfield
    RH8 0SQ Oxted
    Surrey
    BritishChartered Accountant3911520002
    PARKER, Roy David
    Dancote
    Cockernhoe Green
    LU2 8PY Luton
    Bedfordshire
    Diretor
    Dancote
    Cockernhoe Green
    LU2 8PY Luton
    Bedfordshire
    BritishChartered Accountant6523320003
    SHARP, Gary
    Clough Green Farm
    Cawthorne
    S75 4AB Barnsley
    South Yorkshire
    Diretor
    Clough Green Farm
    Cawthorne
    S75 4AB Barnsley
    South Yorkshire
    BritishTransport Controller92322610001
    SMITH, Philip Michael Forster
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    19 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant35806430001
    SPEAK, Iain Alexander
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    Diretor
    Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    105
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director54684840001
    YOUNG, Paul Andrew
    5 Manorial Road
    Roughley
    B75 5UD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    5 Manorial Road
    Roughley
    B75 5UD Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishBusiness Development62012260003
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Diretor nomeado
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Diretor nomeado
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001

    HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 01/08/2011
    Entregue em 13/08/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 13/08/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 21/09/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 07/09/2005
    Entregue em 17/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 17/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 02/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 17/01/2003
    Entregue em 28/01/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/01/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 28/08/1998
    Entregue em 17/09/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or hammond logistics group limited and/or rickaby and lee transport limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 17/09/1998Registro de uma garantia (395)
    • 09/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 21/08/1995
    Entregue em 22/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I PLC as Security Trustee for Itself and as Trustee on Behalf of the Noteholders (As Defined)
    Transações
    • 22/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 24/07/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 12/08/1993
    Entregue em 24/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or hammond group li ited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 09/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    HAMMOND GROUP HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    22/09/2014Início da liquidação
    14/12/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Profissional
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Profissional
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0