EXBIRCO 2 LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | EXBIRCO 2 LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 02779829 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de EXBIRCO 2 LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica EXBIRCO 2 LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de EXBIRCO 2 LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
BIRCHWOOD OMNIA LIMITED | 06/09/1994 | 06/09/1994 |
DEECRETE CONCRETE PRODUCTS LIMITED | 17/02/1993 | 17/02/1993 |
SMARTFREE LIMITED | 15/01/1993 | 15/01/1993 |
Quais são as últimas contas de EXBIRCO 2 LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 30/09/2011 |
Quais são as últimas submissões para EXBIRCO 2 LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital em 14/05/2013
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/01/2013 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/01/2012 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/01/2011 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de John William Young Strachan Samuel como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2009 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/01/2010 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Contas preparadas até 30/09/2008 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 353 | ||||||||||
Contas preparadas até 30/09/2007 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Diversos Section 394 | 1 páginas | MISC |
Quem são os diretores de EXBIRCO 2 LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENEW NOMINEES LIMITED | Secretário | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 41291250014 | |||||||
SAMUEL, John William Young Strachan | Diretor | Main Street North Aberford LS25 3AA Leeds Yew Trees | England | British | Chartered Accountant | 3909060002 | ||||
SAMUEL, John William Young Strachan | Diretor | Main Street North Aberford LS25 3AA Leeds Yew Trees West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 3909060002 | ||||
RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Diretor | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 91993060004 | |||||||
BARKER, James Alan | Secretário | 20 Crabtree Park GL7 4LT Fairford Gloucestershire | British | 31113100001 | ||||||
FOTHERGIL, John | Secretário | 23 Dale Road Sadberge DL2 1ST Darlington County Durham | British | 49915210001 | ||||||
LOWE, Ann Elizabeth | Secretário | 22 Moulton Grove Fairfield TS19 7RH Stockton On Tees Cleveland | British | 37555390001 | ||||||
WADE, Barry Anthony | Secretário | 161 Palmerston Street Westwood NG16 5HZ Nottingham Nottinghamshire | British | Company Director | 150120001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARKER, James Alan | Diretor | 20 Crabtree Park GL7 4LT Fairford Gloucestershire | British | Finance Director | 31113100001 | |||||
BISHOP, Michael John | Diretor | Britannia House Staverton Technology Park GL51 6TQ Cheltenham Gloucestershire | British | Company Director | 11164490003 | |||||
DARLINGTON, Stephen Jeffrey | Diretor | Ty Gwyn Mentone Avenue Aspley Guise MK17 8EQ Milton Keynes Bedfordshire | British | Accountant | 43547190001 | |||||
DENMAN, Charles Edward | Diretor | 97 Jubilee Close Melbourne DE73 8GR Derby Derbyshire | British | Company Director | 102694530001 | |||||
FEENAN, Gerard | Diretor | 191 Upton Road CH43 7QF Prenton Merseyside | United Kingdom | British | Sales And Marketing Director | 122236830001 | ||||
FOREMAN, David Howard | Diretor | 6 Bassenthwaite Avenue DH2 3HB Chester Le Street County Durham | British | Director | 38713240001 | |||||
FOTHERGIL, John | Diretor | 23 Dale Road Sadberge DL2 1ST Darlington County Durham | British | Director | 49915210001 | |||||
HEWLETT, David | Diretor | Roseland 22 Aylsham Road NR11 6TE Tuttington Norfolk | England | British | Company Director | 87102720001 | ||||
LEE, Thomas Joseph | Diretor | Briardene Brancepeth Chare SR8 1LU Peterlee Durham | British | Company Director | 54828280001 | |||||
LOWE, Keith | Diretor | 22 Moulton Grove Fairfield TS19 7RH Stockton On Tees Cleveland | British | Company Director | 18760810001 | |||||
MCARTHUR, Alexander Nigel | Diretor | 39 Cornhill EC3V 3NU London | British | Chartered Accountant | 1571200002 | |||||
MOORE, Patrick John | Diretor | 5 Old Hall Gardens Coddington NG24 2QJ Newark Nottinghamshire | British | Company Director | 23123380001 | |||||
NELMES CROCKER, Michael | Diretor | Chartleys Box GL6 9HR Minchinhampton Stroud Gloucestershire | British | Company Director | 1729130003 | |||||
SELLARS, Paul | Diretor | White House Withyham TN7 4BT Hartfield East Sussex | England | British | Finance Director | 50761250001 | ||||
TAVERNER, Torquil Graham | Diretor | Rosedale Deighton DL6 2SJ Northallerton North Yorkshire | England | British | Director | 90749940001 | ||||
TWELLS, Paul Stephen | Diretor | 158 Ingram Road NG6 9GQ Bulwell Nottingham | British | Company Director | 51937070001 | |||||
WADE, Barry Anthony | Diretor | 161 Palmerston Street Westwood NG16 5HZ Nottingham Nottinghamshire | British | Company Director | 150120001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
EXBIRCO 2 LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Criado em 21/07/2000 Entregue em 27/07/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido The chargor covenanted that it will demand in writing made to it by the security trustee pay or discharge to the security trustee all money and liabilities at the debenture date or in the future due owing or incurred to each beneficiary as and when the same falls due for payment by the chargor | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 15/08/1997 Entregue em 02/09/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 15/11/1995 Entregue em 21/11/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 10/05/1995 Entregue em 16/05/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The f/h property k/a plot 22/2 lying to the north of pattinson road and the east side of wilden road washington tyne & wear title number TY245654 and the proceeds of sale. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 24/05/1993 Entregue em 08/06/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the sale agreement | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Corporatee mortgage | Criado em 25/03/1993 Entregue em 01/04/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 18/03/93 | |
Breve descrição Kalmar forklift truck 18TON capacity DC16.1200.330122322 Filsmoser decoiling machine serial no RA100/4/5/71 cavalier 2 litre gli reg J621 mvr peugot 405 M16 reg H448 dnl volkswagen golf gti reg K269 rty tog with engines and spare parts the benefit of all contracts logbooks records the benefit of all insurances any moneys payable to the company in connection with a sale. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 25/03/1993 Entregue em 31/03/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0