EXBIRCO 2 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaEXBIRCO 2 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02779829
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de EXBIRCO 2 LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica EXBIRCO 2 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de EXBIRCO 2 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BIRCHWOOD OMNIA LIMITED06/09/199406/09/1994
    DEECRETE CONCRETE PRODUCTS LIMITED17/02/199317/02/1993
    SMARTFREE LIMITED15/01/199315/01/1993

    Quais são as últimas contas de EXBIRCO 2 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2011

    Quais são as últimas submissões para EXBIRCO 2 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Estado do capital em 14/05/2013

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Declaração anual preparada até 01/01/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 01/01/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2011

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/01/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2010

    5 páginasAA

    Nomeação de John William Young Strachan Samuel como diretor

    3 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2009

    8 páginasAA

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada

    1 páginasAD03

    Declaração anual preparada até 01/01/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado

    1 páginasAD02

    legacy

    3 páginas363a

    Contas preparadas até 30/09/2008

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginas353

    Contas preparadas até 30/09/2007

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Diversos

    Section 394
    1 páginasMISC

    Quem são os diretores de EXBIRCO 2 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Secretário
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Diretor
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritishChartered Accountant3909060002
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    Diretor
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Diretor
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Secretário
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    FOTHERGIL, John
    23 Dale Road
    Sadberge
    DL2 1ST Darlington
    County Durham
    Secretário
    23 Dale Road
    Sadberge
    DL2 1ST Darlington
    County Durham
    British49915210001
    LOWE, Ann Elizabeth
    22 Moulton Grove
    Fairfield
    TS19 7RH Stockton On Tees
    Cleveland
    Secretário
    22 Moulton Grove
    Fairfield
    TS19 7RH Stockton On Tees
    Cleveland
    British37555390001
    WADE, Barry Anthony
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretário
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director150120001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Diretor
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    BritishFinance Director31113100001
    BISHOP, Michael John
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director11164490003
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Diretor
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    BritishAccountant43547190001
    DENMAN, Charles Edward
    97 Jubilee Close
    Melbourne
    DE73 8GR Derby
    Derbyshire
    Diretor
    97 Jubilee Close
    Melbourne
    DE73 8GR Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director102694530001
    FEENAN, Gerard
    191 Upton Road
    CH43 7QF Prenton
    Merseyside
    Diretor
    191 Upton Road
    CH43 7QF Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritishSales And Marketing Director122236830001
    FOREMAN, David Howard
    6 Bassenthwaite Avenue
    DH2 3HB Chester Le Street
    County Durham
    Diretor
    6 Bassenthwaite Avenue
    DH2 3HB Chester Le Street
    County Durham
    BritishDirector38713240001
    FOTHERGIL, John
    23 Dale Road
    Sadberge
    DL2 1ST Darlington
    County Durham
    Diretor
    23 Dale Road
    Sadberge
    DL2 1ST Darlington
    County Durham
    BritishDirector49915210001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Diretor
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director87102720001
    LEE, Thomas Joseph
    Briardene Brancepeth Chare
    SR8 1LU Peterlee
    Durham
    Diretor
    Briardene Brancepeth Chare
    SR8 1LU Peterlee
    Durham
    BritishCompany Director54828280001
    LOWE, Keith
    22 Moulton Grove
    Fairfield
    TS19 7RH Stockton On Tees
    Cleveland
    Diretor
    22 Moulton Grove
    Fairfield
    TS19 7RH Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director18760810001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Diretor
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    BritishChartered Accountant1571200002
    MOORE, Patrick John
    5 Old Hall Gardens
    Coddington
    NG24 2QJ Newark
    Nottinghamshire
    Diretor
    5 Old Hall Gardens
    Coddington
    NG24 2QJ Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director23123380001
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Diretor
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director1729130003
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Diretor
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritishFinance Director50761250001
    TAVERNER, Torquil Graham
    Rosedale
    Deighton
    DL6 2SJ Northallerton
    North Yorkshire
    Diretor
    Rosedale
    Deighton
    DL6 2SJ Northallerton
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector90749940001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Diretor
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    BritishCompany Director51937070001
    WADE, Barry Anthony
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director150120001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    EXBIRCO 2 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 21/07/2000
    Entregue em 27/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The chargor covenanted that it will demand in writing made to it by the security trustee pay or discharge to the security trustee all money and liabilities at the debenture date or in the future due owing or incurred to each beneficiary as and when the same falls due for payment by the chargor
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 27/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 15/08/1997
    Entregue em 02/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Criado em 15/11/1995
    Entregue em 21/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 21/11/1995Registro de uma garantia (395)
    • 02/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 10/05/1995
    Entregue em 16/05/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a plot 22/2 lying to the north of pattinson road and the east side of wilden road washington tyne & wear title number TY245654 and the proceeds of sale.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 16/05/1995Registro de uma garantia (395)
    • 02/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 24/05/1993
    Entregue em 08/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the sale agreement
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Omnia Group Limited
    Transações
    • 08/06/1993Registro de uma garantia (395)
    • 03/02/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Corporatee mortgage
    Criado em 25/03/1993
    Entregue em 01/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 18/03/93
    Breve descrição
    Kalmar forklift truck 18TON capacity DC16.1200.330122322 Filsmoser decoiling machine serial no RA100/4/5/71 cavalier 2 litre gli reg J621 mvr peugot 405 M16 reg H448 dnl volkswagen golf gti reg K269 rty tog with engines and spare parts the benefit of all contracts logbooks records the benefit of all insurances any moneys payable to the company in connection with a sale.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 01/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 25/03/1993
    Entregue em 31/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 31/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0