CAPITAL REVERSIONS LIMITED

CAPITAL REVERSIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCAPITAL REVERSIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02784657
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CAPITAL REVERSIONS LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção

    Onde fica CAPITAL REVERSIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Cross House
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CAPITAL REVERSIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CAPITAL REVERSIONS PLC08/02/199308/02/1993
    TRUNKGLADE PLC28/01/199328/01/1993

    Quais são as últimas contas de CAPITAL REVERSIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2018

    Quais são as últimas submissões para CAPITAL REVERSIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 03/01/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2018

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 04/01/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2017

    7 páginasAA

    Satisfação total da garantia 14

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 05/01/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN para Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX

    1 páginasAD02

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX

    1 páginasAD04

    Alteração dos detalhes de Sovereign Reversions Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 05/07/2017

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de 17 Dominion Street London EC2M 2EF United Kingdom para Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX em 11/07/2017

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Antony Lewis Pierce como diretor em 05/07/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Paul Trevor Barber como diretor em 05/07/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Robert John Calnan como diretor em 05/07/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Neal Morar como diretor em 05/07/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Neal Morar como secretário em 05/07/2017

    1 páginasTM02

    Exercício contabilístico atual encurtado de 31/12/2017 para 30/09/2017

    1 páginasAA01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    5 páginasAA

    Satisfação total da garantia 10

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 11

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 2

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 1

    1 páginasMR04

    Quem são os diretores de CAPITAL REVERSIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BARBER, Paul Trevor
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    Diretor
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive230642640001
    PIERCE, Antony Lewis
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    Diretor
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director156315340001
    CAVES, John Edward
    27 Northill Road
    Cople
    MK44 3TU Bedford
    Bedfordshire
    Secretário
    27 Northill Road
    Cople
    MK44 3TU Bedford
    Bedfordshire
    British2580410002
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Secretário
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    198662300001
    ROBERTS, Catherine Jane
    2 Birch Close
    Greenfield Road Harborne
    B17 0EH Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    2 Birch Close
    Greenfield Road Harborne
    B17 0EH Birmingham
    West Midlands
    BritishTrainee Solicitor41316540001
    THOMAS, Mark Owen
    19 Woodlands Close
    Cople
    MK44 3UE Bedford
    Bedfordshire
    Secretário
    19 Woodlands Close
    Cople
    MK44 3UE Bedford
    Bedfordshire
    EnglishAccountant105743750001
    WINDLE, Michael Patrick
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    Secretário
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    British156117170001
    CAPITAL VENTURES LIMITED
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Secretário
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    4933620020
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretário nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BARBER, Paul Trevor
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Diretor
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director121775760002
    BILTON, Anton John Godfrey
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    Diretor
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    BritishCompany Director21454000001
    BRUCKLAND, Andrew John
    18 Eldorado Road
    GL50 2PT Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    18 Eldorado Road
    GL50 2PT Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director22103780002
    BURGESS, Susan Ann
    22 Tyburn Lane
    MK45 5HG Pulloxhill
    Bedfordshire
    Diretor
    22 Tyburn Lane
    MK45 5HG Pulloxhill
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant46558140002
    CALNAN, Robert John
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Diretor
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor197408030001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Littleworth
    Amberley
    GL5 5AG Stroud
    Follifoot House
    Gloucestershire
    Diretor
    Littleworth
    Amberley
    GL5 5AG Stroud
    Follifoot House
    Gloucestershire
    UkBritishCompany Director156117090001
    ECKERSLEY, Edward Kenneth
    26 Park Crescent
    RH18 5ED Forest Row
    East Sussex
    Diretor
    26 Park Crescent
    RH18 5ED Forest Row
    East Sussex
    BritishGeneral Management Consultant378050001
    HARE SCOTT, Nigel Trewren
    Staffords
    Churchgate Street
    CM17 0JR Old Harlow
    3
    Essex
    Diretor
    Staffords
    Churchgate Street
    CM17 0JR Old Harlow
    3
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant136497510001
    LITTLE, Simon
    4 Yeates Close
    Off Byford Way
    MK18 3RH Winslow
    Buckinghamshire
    Diretor
    4 Yeates Close
    Off Byford Way
    MK18 3RH Winslow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director123953930001
    MARSHALL, Graeme Calder Walker
    Black Knoll House Rhinefield Road
    SO42 7QE Brockenhurst
    Hampshire
    Diretor
    Black Knoll House Rhinefield Road
    SO42 7QE Brockenhurst
    Hampshire
    EnglandBritishDirector56957920002
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Diretor
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director173110500001
    ON, Nicholas Peter
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Diretor
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishLawyer135860930002
    PEARCE GOULD, Rupert Anthony
    Church Street
    Harston
    CB22 7NP Cambridge
    65
    Cambridgeshire
    Diretor
    Church Street
    Harston
    CB22 7NP Cambridge
    65
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishDirector2230820002
    PSYLLIDES, Milton Nicholas
    Westfield 1 Halloughton Road
    Four Oaks
    B74 2QG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    Westfield 1 Halloughton Road
    Four Oaks
    B74 2QG Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishSolicitor33137230002
    ROBERTS, Catherine Jane
    2 Birch Close
    Greenfield Road Harborne
    B17 0EH Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    2 Birch Close
    Greenfield Road Harborne
    B17 0EH Birmingham
    West Midlands
    BritishTrainee Solicitor41316540001
    SIDWELL, Graham Robert
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Diretor
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone72844280004
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CAPITAL REVERSIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    24/05/2016
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro07619855
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    CAPITAL REVERSIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 25/07/2011
    Entregue em 29/07/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transações
    • 29/07/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 30/01/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Mortgage
    Criado em 01/08/2007
    Entregue em 10/08/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and sovereign reversions PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Allied Irish Banks PLC
    Transações
    • 10/08/2007Registro de uma garantia (395)
    • 06/04/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 14/03/1995
    Entregue em 15/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 3 march 1995
    Breve descrição
    9 grainger court, 235 graham road, sheffield.
    Pessoas com direito
    • Marjorie Joyce Ward
    • Kenneth Ward
    Transações
    • 15/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 17/01/1995
    Entregue em 24/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 6 january 1995
    Breve descrição
    F/H property situate at 116 caledonian glascote heath tamworth staffordshire.
    Pessoas com direito
    • Harold Taylor
    • Dorothy Irene Taylor
    Transações
    • 24/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 29/07/1994
    Entregue em 09/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 15 july 1994
    Breve descrição
    L/H property situate at 60A knighton court,lyme view road,torquay,south devon.
    Pessoas com direito
    • Estella Alphonsus Gittus
    Transações
    • 09/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 29/07/1994
    Entregue em 09/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 15 july 1994
    Breve descrição
    L/H property situate at 134 healey wood road,brighouse,west yorkshire.
    Pessoas com direito
    • Nora Harrison
    • George Harrison
    Transações
    • 09/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 29/07/1994
    Entregue em 09/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 19 july 1994
    Breve descrição
    F/H property situate at 55 whitehouse road,woodcote,oxon.
    Pessoas com direito
    • John Devenny
    • Doris Isabella Devanny
    Transações
    • 09/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 27/07/1994
    Entregue em 03/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The sum equilavent to the retained interest due from the company to the chargee in accordance with the contract dated 14 july 1994.
    Breve descrição
    F/H property situate at 48 barnet drive bromley,kent.
    Pessoas com direito
    • Mary James
    • Evan Desmond James
    Transações
    • 03/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 08/04/1994
    Entregue em 13/04/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 31ST march 1994
    Breve descrição
    L/H property situate at 16 rose avenue, haydock, st. Helens, merseyside.
    Pessoas com direito
    • Eric Collier
    Transações
    • 13/04/1994Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 25/02/1994
    Entregue em 15/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The sum equivalent to the retained interest due from the company to the chargee in accordance with the contract dated 17TH february 1994
    Breve descrição
    F/H property situate at 7 childs way london NW11.
    Pessoas com direito
    • Joan Laurance Laurance
    • Patrick Knowles Laurance
    Transações
    • 15/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 05/03/2020Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 22/02/1994
    Entregue em 15/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The sum equivalent to the retained interest due from the company to the chargee in accordance with the contract dated 10TH february 1994
    Breve descrição
    L/H property situate at 39 ringstead avenue sheffield.
    Pessoas com direito
    • Albert Eric Stringfellow
    • Mary Alice Stringfellow
    Transações
    • 15/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 06/12/1993
    Entregue em 08/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 17TH november 1993
    Breve descrição
    L/H property situate at 19 burley orchard, staines lane, chertsey, surrey.
    Pessoas com direito
    • Leslie Cooper and Gwendoline Mirob Cooper
    Transações
    • 08/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 16/11/1993
    Entregue em 23/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 8TH november 1993
    Breve descrição
    F/H property situate at 9 bridgewater drive, vicars cross, chester cheshire.
    Pessoas com direito
    • Mavis Juliet Fratel
    Transações
    • 23/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 10/11/1993
    Entregue em 20/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee equivalent to the retained interest of the chargee in accordance with the contract dated 1ST november 1993
    Breve descrição
    F/H property situate at 15 audley avenue, gillingham, kent.
    Pessoas com direito
    • V. Niblett and J.G.N. Niblett
    Transações
    • 20/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/2017Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0