MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02801072 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?
- Outras edições de software (58290) / Informação e comunicação
Onde fica MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | One Kingdom Street Paddington W2 6BL London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| THE FRUSTUM GROUP (EUROPE) LIMITED | 18/03/1993 | 18/03/1993 |
Quais são as últimas contas de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/05/2014 |
Qual é o status da última declaração anual para MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 01/04/2015
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 18/03/2015 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/05/2014 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Andrew Paul Woodward como diretor em 05/09/2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Sanjay Patel como diretor em 28/08/2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr John Van Harken como diretor em 31/07/2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Elizabeth Mary Collins como diretor em 31/07/2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 18/03/2014 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/05/2013 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mrs Elizabeth Mary Collins como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Misys Corporate Director Limited como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Joanna Hawkes como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Misys Corporate Secretary Limited como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Sanjay Patel como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Joanna Marageret Hawkes como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Bijal Patel como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Thomas Edward Timothy Homer em 20/05/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 18/03/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/05/2012 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Nicholas Farrimond como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Bijal Mahendra Patel como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKEN, John Van | Diretor | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | American | 183654340001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Diretor | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Diretor | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 100885620001 | |||||||||
| BAINS, Gurbinder | Secretário | Kingston Road UB2 4AP Southall 36 Middlesex United Kingdom | Other | 138753780001 | ||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Secretário | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Secretário | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Secretário | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| STOKOE, Anthony | Secretário | 4 Clifton Road KT2 6PW Kingston Upon Thames Surrey | British | 29734520002 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Secretário | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretário | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom |
| 149996410001 | ||||||||||
| SECORP LIMITED | Secretário | PO BOX 556, Hunkins Waterfront Plaza, Main Street Charlestown Nevis West Indies | 93219460001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| COLLINS, Elizabeth Mary | Diretor | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 180406780001 | |||||||||
| DARBY, Andrew Hamish | Diretor | 9a Oatlands Chase KT13 9RF Weybridge Surrey | England | British | 114800800001 | |||||||||
| DAVIS, Steven Rogers | Diretor | 71 Gerrish Lane New Canaan Connecticut 06840 Usa | United States | American | 42813140002 | |||||||||
| DEMETRIOS, Helen | Diretor | 316 Stonehill Road 10576 Pound Ridge New York United States | American | 34271630002 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Diretor | The Avenue Watford WD17 4NU Hertfordshire 51 England England | England | British | 75357260001 | |||||||||
| FLOCK, Charles | Diretor | 42 West Clinton Avenue 10533 Irvington New Yok United States Of America | American | 34271860002 | ||||||||||
| GRAHAM, Ross King | Diretor | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAWKES, Joanna Marageret | Diretor | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 136214800001 | |||||||||
| HELSBY, Frank Peter | Diretor | 27 Park Green Great Bookham KT23 3NL Leatherhead Surrey | England | British | 34237710003 | |||||||||
| HUGHES, Kevin Gerard | Diretor | 31 Cromwell Avenue Billericay CM12 OAG Essex | United Kingdom | British | 173214140001 | |||||||||
| JAUFERING, Robert Russell | Diretor | 5 Monck Street SW1P 2BW London | American | 37636270001 | ||||||||||
| PATEL, Bijal Mahendra | Diretor | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street | United Kingdom | British | 161424380001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Surendra | Diretor | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 147221810001 | |||||||||
| PEDDAR, Richard Granville | Diretor | 14 Lower Common South Putney SW15 1BP London | British | 57803270001 | ||||||||||
| SOMMERS, Gary | Diretor | 10 Shoshone Drive 10526 Golders Bridge New York United States | American | 34272070002 | ||||||||||
| SPADAFORA, Fred Jphn | Diretor | 3 Heathview Court Corringway NW11 7EF London | American | 52601930001 | ||||||||||
| STADTHER, Michael | Diretor | 316 Stonehill Road 10576 Pound Ridge New York United States | American | 34271760002 | ||||||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Diretor | Blythe House 10 Grange Road Bidford On Avon B50 4BY Alcester Warwickshire | England | British | 1442450002 | |||||||||
| WHITE, Andrew Ian | Diretor | Hillcott Perrotts Brook GL7 7BN Cirencester Glos | United Kingdom | British | 93602410001 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Diretor | Kingdom Street Paddington W2 6BL London 1 | 82836510002 |
MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Criado em 17/09/2003 Entregue em 01/10/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Criado em 11/09/2003 Entregue em 24/09/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Criado em 29/07/2003 Entregue em 12/08/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Criado em 23/10/2002 Entregue em 13/11/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 | Criado em 09/05/2002 Entregue em 25/05/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0