UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED

UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaUNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02820274
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    3 Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Surrey
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 07/05/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Nomeação de Ms Siobhan Mary Hextall como diretor em 03/01/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Alan John Turner como diretor em 15/12/2016

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 3 Guildford Business Park Guildford England and Wales GU2 8XG United Kingdom para 3 Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XG em 03/08/2016

    1 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de Avaya House 2 Cathedral Hill Guildford Surrey GU2 7YL para 3 Guildford Business Park Guildford England and Wales GU2 8XG em 02/08/2016

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 07/05/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital27/05/2016

    Estado do capital em 27/05/2016

    • Capital: USD 2
    SH01

    Declaração anual preparada até 07/05/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/05/2015

    Estado do capital em 12/05/2015

    • Capital: USD 2
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    13 páginasAA

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    13 páginasAA

    Nomeação de Mr Derek Robert Douglas Reid como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Theo Wilkes como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 07/05/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/05/2014

    Estado do capital em 15/05/2014

    • Capital: USD 2
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 07/05/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Nomeação de Theo James Rickus Wilkes como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Gareth Nokes como diretor

    1 páginasTM01

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 07/05/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    Quem são os diretores de UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HEXTALL, Siobhan Mary
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Irish65283470005
    HEXTALL, Siobhan Mary
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomIrishAccountant65283470005
    REID, Derek Robert Douglas
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishLegal Director97706670003
    THOMAS, Clive Paul
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant170854570001
    COOPER, Bradley Eric
    145 West 67th Street Apartment 21 J
    New York 10023
    United States Of America
    Secretário
    145 West 67th Street Apartment 21 J
    New York 10023
    United States Of America
    AmericanInvestment Fund Manager34977460001
    COOPER, Peter James
    4 Verley Close
    Woughton On The Green
    MK6 3ER Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretário
    4 Verley Close
    Woughton On The Green
    MK6 3ER Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director7369200002
    JONES, Graham Keith
    20 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    Secretário
    20 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    British85729910002
    MASON, Kira
    11 Norham Court
    Park Farm
    PE2 8UX Peterborough
    Cambridgeshire
    Secretário
    11 Norham Court
    Park Farm
    PE2 8UX Peterborough
    Cambridgeshire
    British96872510001
    SMITH, Trevor Robert
    29 Spurgate
    Hutton
    CM13 2JS Brentwood
    Essex
    Secretário
    29 Spurgate
    Hutton
    CM13 2JS Brentwood
    Essex
    British38682070002
    VERNON, Michael David Lang
    19 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Secretário
    19 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    British3005460002
    WITTY, Simon David Kingsley
    6 Dolby Road
    SW6 3NE London
    Secretário
    6 Dolby Road
    SW6 3NE London
    BritishSolicitor34787610001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretário nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BECKER, Bernard Frederick
    1760 Knollwood Lane
    60045 Lake Forest
    Illinois
    Usa
    Diretor
    1760 Knollwood Lane
    60045 Lake Forest
    Illinois
    Usa
    AmericanDirector Of Companies46940660001
    BISHOP, Alasdair Graham
    4 Weston Park
    Weston Green
    KT7 0HQ Thames Ditton
    Diretor
    4 Weston Park
    Weston Green
    KT7 0HQ Thames Ditton
    EnglandBritishStatistician37133500003
    BRADLEY, Thomas Andrew, Mr.
    13 Crocus Hill
    55102 St Paul
    Minnesota 55102
    United States
    Diretor
    13 Crocus Hill
    55102 St Paul
    Minnesota 55102
    United States
    UsaUnited StatesInsurance Executive72006090001
    COOPER, Bradley Eric
    145 West 67th Street Apartment 21 J
    New York 10023
    United States Of America
    Diretor
    145 West 67th Street Apartment 21 J
    New York 10023
    United States Of America
    AmericanInvestment Fund Manager34977460001
    COOPER, Peter James
    Woodland View
    4 Brassey Close
    RH8 0EX Limpsfield
    Surrey
    Diretor
    Woodland View
    4 Brassey Close
    RH8 0EX Limpsfield
    Surrey
    BritishChartered Accountant7369200008
    DILLEY, Anthony John
    Armiger Way
    CM8 2UY Witham
    13
    Essex
    Diretor
    Armiger Way
    CM8 2UY Witham
    13
    Essex
    United KingdomBritishCoo39830800001
    EYRE, Howard Guy
    Box Cottage
    The Street
    TN26 3AD Bethersden
    Kent
    Diretor
    Box Cottage
    The Street
    TN26 3AD Bethersden
    Kent
    BritishClaims Director75164360001
    FREED, Jeffrey Howard
    1474 Third Avenue Apartment 10-N
    10028 New York
    Usa
    Diretor
    1474 Third Avenue Apartment 10-N
    10028 New York
    Usa
    BritishBanker40379370001
    FREY, Daniel Stephen
    194 Sunset Ridge
    Rocky Hill
    Connecticut Ct 06067
    United States
    Diretor
    194 Sunset Ridge
    Rocky Hill
    Connecticut Ct 06067
    United States
    United States CitizenChief Financial Officer103701410001
    GARMOYLE, Hugh Sebastian Frederick, Viscount
    11 Lonsdale Road
    W11 2BY London
    Diretor
    11 Lonsdale Road
    W11 2BY London
    BritishSolicitor64019250001
    GRUBER, Steven Bennett
    18 Richbell Road
    Scarsdale
    New York
    10583
    Usa
    Diretor
    18 Richbell Road
    Scarsdale
    New York
    10583
    Usa
    United StatesAmericanBanker276904280001
    MARCELL, Philip Michael
    Weavers End
    Church Lane
    GU27 2BJ Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Weavers End
    Church Lane
    GU27 2BJ Haslemere
    Surrey
    BritishReinsurance Executive7369280001
    NICHOLS, Thomas James
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    Diretor
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    EnglandBritishAccountant129335930001
    NOKES, Gareth Howard John
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    Diretor
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    EnglandEnglishAccountant141023860001
    RICHARDS, Andrew Phillip
    22 Melrose Gardens
    W6 7RW London
    Diretor
    22 Melrose Gardens
    W6 7RW London
    BritishSolicitor22232040001
    SINCLAIR, Ian Gordon
    14 Capstan Close
    CB4 1BJ Cambridge
    Diretor
    14 Capstan Close
    CB4 1BJ Cambridge
    BritishUnderwriter26686870004
    SPASS, Robert Alan
    10 Floral Court Westfield
    Union New Jersey 7090
    Usa
    Diretor
    10 Floral Court Westfield
    Union New Jersey 7090
    Usa
    AmericanFund Manager41412510001
    TIMPONE, Stephen
    264 Kelly Boulevard
    Staten Island
    New York 10314
    United States
    Diretor
    264 Kelly Boulevard
    Staten Island
    New York 10314
    United States
    United States CitizenChief Financial Officer118897800001
    TURNER, Alan John
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant103211340004
    URNESS, Kent Douglas
    1320 Strawberry Hill Road
    Afton
    Minnesota
    United States Of America
    Diretor
    1320 Strawberry Hill Road
    Afton
    Minnesota
    United States Of America
    AmericanInsurance Executive69858870001
    WARREN, Paul Hendrick
    360 East 88th Street
    Apartment 40b New York 10128
    Usa
    Diretor
    360 East 88th Street
    Apartment 40b New York 10128
    Usa
    AmericanInvestment Fund Manager41412710001
    WILKES, Theo James Rickus
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    Diretor
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant172126980001

    Quem são as pessoas com controle significativo de UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    England
    06/04/2016
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    3
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalThe Companies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro02822469
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    UNIONAMERICA ACQUISITION COMPANY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 10/02/2009
    Entregue em 10/02/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • National Australia Bank Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transações
    • 10/02/2009Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Charge of deposit
    Criado em 30/11/1998
    Entregue em 04/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The deposit initially of £11,300,000 credited to account designation 91054631 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 04/12/1998Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 30/06/1998
    Entregue em 10/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms or in respect of the £790,500 loan notes issued by the company to the chargees pursuant to an instrument by way of deed poll of even date together with all other monies liable under or in connection with the loan notes
    Breve descrição
    Fixed charge over all sums of money deposited now or in the future in account no. 38321981 at coutts & co 15 lombard street london or any substitution or replacement thereof including any interest accruing except to the extent provided for under condition 3.5 of the instrument by way of deed poll dated 30TH june 1998. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • John Young
    • Simon Turner
    • Holly Bellingham
    Transações
    • 10/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Criado em 23/12/1997
    Entregue em 02/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The deposit initially of £8,000,000 credited to account number/designation 91054631 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of the company with the bank of any other currency description designation or numbering which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or any part of it.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 02/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 29/04/1997
    Entregue em 14/05/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and ua management company to the chargee as agent and trustee for itself and the lenders (as defined) or any of them under each or any of the finance documents to which the company is a party
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Chase Manhattan International Limited
    Transações
    • 14/05/1997Registro de uma garantia (395)
    • 27/01/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental debenture
    Criado em 31/08/1995
    Entregue em 14/09/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or ua management company to the chargee under each or any of the senior finance documents
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Chase Manhattan Bank, N.A.(As Agent and Trustee for Itself and Other Lenders) (the "Security Agent")
    Transações
    • 14/09/1995Registro de uma garantia (395)
    • 29/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 18/03/1994
    Entregue em 07/04/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or ua management company to the chargee under the terms of the senior finance documents (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Other Lenders)
    Transações
    • 07/04/1994Registro de uma garantia (395)
    • 27/01/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 10/09/1993
    Entregue em 24/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due from the company and/or unionamerica acquisition company limited to the chargee under the terms of each or any of the senior finance documents (as defined)
    Breve descrição
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Chase Manhattan Bank,N.A.as Agent and Trustee for Itself and Other Lenders (The "Security Agent")
    Transações
    • 24/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 29/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0