MELIORA SPECTARE LIMITED

MELIORA SPECTARE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMELIORA SPECTARE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02845804
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MELIORA SPECTARE LIMITED?

    • Atividades de outras sociedades holding n.e.c. (64209) / Atividades financeiras e de seguros
    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica MELIORA SPECTARE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MELIORA SPECTARE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    IMCO (1693) LIMITED18/08/199318/08/1993

    Quais são as últimas contas de MELIORA SPECTARE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2012

    Quais são as últimas submissões para MELIORA SPECTARE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    4 páginasDS01

    Término da nomeação de Michael James Kachmer como diretor em 03/04/2013

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    7 páginasAA

    Estado do capital em 24/12/2012

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    8 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Share premium account & capital redemption reserve cancelled 14/12/2012
    RES13

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Consent to passing of resolution 14/12/2012
    RES13

    Declaração anual preparada até 18/08/2012 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    7 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 18/08/2011 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01

    Nomeação de Graham Philip Brisley Veal como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Kevin Blades como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 18/08/2010 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Prima Secretary Limited em 18/08/2010

    2 páginasCH04

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    7 páginasAA

    Término da nomeação de Thomas Doerr como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Adrian David Gray como diretor

    3 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    7 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas288a

    Quem são os diretores de MELIORA SPECTARE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Secretário
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Diretor
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritishAccountant146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Diretor
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmericanCompany Director134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Diretor
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development Director43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Secretário
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    CUNNINGHAM, Kevin Gerard
    56 Stumperlowe Crescent Road
    Fulwood
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Secretário
    56 Stumperlowe Crescent Road
    Fulwood
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    BritishSolicitor91193580001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Secretário
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    POINTON, Graham
    6 Grasmere Close
    Penistone
    S30 6HP Sheffield
    South Yorkshire
    Secretário
    6 Grasmere Close
    Penistone
    S30 6HP Sheffield
    South Yorkshire
    British3081900001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Secretário
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Secretário nomeado
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British900006640001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Diretor
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritishAccountant79449700002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Diretor
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United StatesSolicitor134081280001
    HARRISON, Andrew Nigel
    54 Conduit Road
    Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor nomeado
    54 Conduit Road
    Sheffield
    South Yorkshire
    British900006650001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Diretor
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary17023730002
    JEFFREY, Nicholas
    Riley Croft
    Eyam
    S32 5QZ Hope Valley
    Diretor
    Riley Croft
    Eyam
    S32 5QZ Hope Valley
    EnglandBritishChief Executive15639340001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Diretor
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmericanCompany Director136570610001
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    Diretor
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,IrishChief Operating Officer32235150003
    SHEPHERD, Eileen
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    Diretor
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    BritishCompany Director68817930001
    SHEPHERD, James Gordon
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    Diretor
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director8474280001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Diretor
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Diretor
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    MELIORA SPECTARE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Criado em 11/04/2002
    Entregue em 25/04/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transações
    • 25/04/2002Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Criado em 20/02/2002
    Entregue em 08/03/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transações
    • 08/03/2002Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Criado em 20/11/2001
    Entregue em 30/11/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 30/11/2001Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 24/11/1993
    Entregue em 02/12/1993
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 02/12/1993Registro de uma garantia (395)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0