REFINED MP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaREFINED MP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02847780
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de REFINED MP LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica REFINED MP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de REFINED MP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MALTHURST PETROLEUM LIMITED21/06/200021/06/2000
    GILLINGHAM SERVICE STATION LIMITED22/10/199822/10/1998
    HEARTS SERVICES LIMITED25/08/199325/08/1993

    Quais são as últimas contas de REFINED MP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para REFINED MP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2018

    8 páginasAA

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado do capital em 30/08/2019

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Reduction of capital redemption reserve 28/08/2019
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Nomeação de Thomas Mckenzie Biggart como diretor em 11/03/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Pinsent Masons Secretarial Limited como secretário em 07/03/2019

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de David Hathaway como secretário em 07/03/2019

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Graham Paul Timbers como diretor em 12/02/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Simon Paul Lane como diretor em 31/12/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr William Bahlsen Bannister como diretor em 31/12/2018

    2 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH para Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU em 02/01/2019

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Steven John Back como diretor em 15/10/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Graham Paul Timbers como diretor em 12/10/2018

    2 páginasAP01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/09/2018 para 31/12/2018

    1 páginasAA01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Karen Juanita Dickens como diretor em 22/06/2018

    1 páginasTM01

    Contas de isenção total preparadas até 01/10/2017

    7 páginasAA

    Exercício contabilístico anterior encurtado de 31/12/2017 para 30/09/2017

    1 páginasAA01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/09/2017 para 31/12/2017

    1 páginasAA01

    Quem são os diretores de REFINED MP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Secretário
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    BIRD, Edwin Arthur
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretário
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British55967160001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Secretário
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    British29587680003
    DOWDING, Charles Michael
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    Secretário
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    British13193130001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Secretário
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    British88005070001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Secretário
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    British117227730001
    KEATING, Roderick Charles
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Secretário
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    British126363230002
    KEIDAN, Michael David Alan
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Secretário
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Other1447490001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACK, Steven John
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Diretor
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Diretor
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    United KingdomBritish29587680003
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Diretor
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Diretor
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    EnglandBritish88005070001
    KING, Joseph
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    Diretor
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    British3635770001
    PEACOCK, Graham Frederick
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Diretor
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish5133310002
    PEACOCK, Graham Frederick
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    Diretor
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    British5133310001
    PEARS, David Alan
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Diretor
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish65200910001
    PEARS, Mark Andrew
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Diretor
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish1447500008
    PEARS, Trevor Steven, Sir
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Diretor
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish40036010005
    ROBINSON, Melvin Frank
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    Diretor
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish146452070001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Diretor
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    EnglandBritish107002130001
    SHARPE, Steven
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    Diretor
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    EnglandBritish146452160001
    THOMPSON, Brian Lane
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    Diretor
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    British56518620001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Diretor
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish17957620003
    TOBBELL, Susan Margaret
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    Diretor
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    United KingdomBritish17957620003
    WPG REGISTRARS LIMITED
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Diretor
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    106986280001

    Quem são as pessoas com controle significativo de REFINED MP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Refined Estates Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    06/04/2016
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro04193995
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    REFINED MP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rental assignation
    Criado em 11/01/2005
    Entregue em 21/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and refined estates limited to the chargee
    Breve descrição
    The benefit of all rents payable under the lease entered into between malthurst petroleum limited, malthurst fuels limited and malthurst UK limited dated 17 november 2003, together with such arrears (if any), including (without limitation) all vat (if any) payable on or in respect of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transações
    • 21/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 21/11/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/12/2004
    Entregue em 23/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Banking Corporation PLC
    Transações
    • 23/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 21/11/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2005 and
    Criado em 15/12/2004
    Entregue em 25/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and whole subjects k/a milngavie service station, glasgow road, milngavie t/n DMB4074.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transações
    • 25/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 21/11/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 15/02/2002
    Entregue em 26/02/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property known as 457 alfreton road nottingham.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 26/02/2002Registro de uma garantia (395)
    • 11/11/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 18/07/2001
    Entregue em 30/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Freehold property k/a little london service station london road spalding lincolnshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 30/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 10/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 22/05/2001
    Entregue em 31/05/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Leasehold property being land and buildings on the south side of norwich road gillingham.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 31/05/2001Registro de uma garantia (395)
    • 11/11/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 22/05/2001
    Entregue em 24/05/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee including all such monies as may fall due for payment under any agreements present and future all costs and expenses all sums due for any goods or services supplied by the chargee to the company, any interest payable to the chargee by the company, or sums which become due to the chargee in connection with any loan, and all sums which become due to the chargee in connection with an externally funded loan
    Breve descrição
    Premises k/a widows cruse filling station gillinham nr beccles norfolk all fixtures and fittings not being personal chattels within the bill of sales act on the premises, all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bp Oil UK Limited
    Transações
    • 24/05/2001Registro de uma garantia (395)
    • 11/11/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 21/05/2001
    Entregue em 30/05/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 30/05/2001Registro de uma garantia (395)
    • 10/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21 june 2001 and
    Criado em 18/05/2001
    Entregue em 26/06/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Milngavie service station, 42 glasgow road, milngavie.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 26/06/2001Registro de uma garantia (395)
    • 10/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 09/02/1996
    Entregue em 28/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a petrol filling station at junction of A143/A146 roads gillingham near beccles norfolk together with all fixtures and fittings at any tim at the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the company at the premises.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 28/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 13/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 09/02/1996
    Entregue em 28/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    L/H property k/a petrol filling station junction A143/A146 roads gillingham nr. Beccles norfolk together with all fixtures fittings at the premises all rental income at any time all rights and claims against any third parties all goodwill full benefit of all contracts of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Mobil Oil Company Limited
    Transações
    • 28/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 13/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge and assignment
    Criado em 19/01/1995
    Entregue em 23/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Petrol filling station development site situate at the junction of A143 and A146 gillingham norfolk all and singular the mortgagor's respective rights title and interest in and to each of the development documents and the development. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Mobil Oil Company Limited
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 23/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 03/06/1994
    Entregue em 10/06/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 10/06/1994Registro de uma garantia (395)
    • 13/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0