REFINED MP LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | REFINED MP LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02847780 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de REFINED MP LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica REFINED MP LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de REFINED MP LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MALTHURST PETROLEUM LIMITED | 21/06/2000 | 21/06/2000 |
| GILLINGHAM SERVICE STATION LIMITED | 22/10/1998 | 22/10/1998 |
| HEARTS SERVICES LIMITED | 25/08/1993 | 25/08/1993 |
Quais são as últimas contas de REFINED MP LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para REFINED MP LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado do capital em 30/08/2019
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nomeação de Thomas Mckenzie Biggart como diretor em 11/03/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nomeação de Pinsent Masons Secretarial Limited como secretário em 07/03/2019 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||||||
Término da nomeação de David Hathaway como secretário em 07/03/2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Graham Paul Timbers como diretor em 12/02/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Simon Paul Lane como diretor em 31/12/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr William Bahlsen Bannister como diretor em 31/12/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH para Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU em 02/01/2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Steven John Back como diretor em 15/10/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Graham Paul Timbers como diretor em 12/10/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/09/2018 para 31/12/2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Karen Juanita Dickens como diretor em 22/06/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 01/10/2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Exercício contabilístico anterior encurtado de 31/12/2017 para 30/09/2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/09/2017 para 31/12/2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de REFINED MP LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secretário | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 76579530001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Bahlsen | Diretor | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | United Kingdom | British | 252731900001 | |||||||||
| BIGGART, Thomas Mckenzie | Diretor | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | Scotland | British | 215843640001 | |||||||||
| LANE, Simon Paul | Diretor | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 252862090001 | |||||||||
| BIRD, Edwin Arthur | Secretário | Hulver Dane O'Coys Road CM23 2JP Bishops Stortford Hertfordshire | British | 55967160001 | ||||||||||
| CAMPBELL, James Oliver | Secretário | 9 Marine Parade Gorleston NR31 6DU Great Yarmouth Norfolk | British | 29587680003 | ||||||||||
| DOWDING, Charles Michael | Secretário | 1 Oakcroft Drive Framingham Earl NR14 7JQ Norwich Norfolk | British | 13193130001 | ||||||||||
| FRENCH, Walter | Secretário | High Farm Bungalow High Farm PE9 3BY Southorpe Lincolnshire | British | 88005070001 | ||||||||||
| HATHAWAY, David | Secretário | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | British | 117227730001 | ||||||||||
| KEATING, Roderick Charles | Secretário | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | British | 126363230002 | ||||||||||
| KEIDAN, Michael David Alan | Secretário | 15 Crooked Usage Finchley N3 3HD London | Other | 1447490001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BACK, Steven John | Diretor | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 205661380001 | |||||||||
| CAMPBELL, James Oliver | Diretor | 9 Marine Parade Gorleston NR31 6DU Great Yarmouth Norfolk | United Kingdom | British | 29587680003 | |||||||||
| DICKENS, Karen Juanita, Dr | Diretor | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 124061360001 | |||||||||
| FRENCH, Walter | Diretor | High Farm Bungalow High Farm PE9 3BY Southorpe Lincolnshire | England | British | 88005070001 | |||||||||
| KING, Joseph | Diretor | Stratford House Stratford Crescent NR4 7SF Cringleford Norfolk | British | 3635770001 | ||||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Diretor | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 5133310002 | |||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Diretor | 5 Brook Street Little Dunmow CM6 3HU Dunmow Essex | British | 5133310001 | ||||||||||
| PEARS, David Alan | Diretor | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 65200910001 | |||||||||
| PEARS, Mark Andrew | Diretor | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 1447500008 | |||||||||
| PEARS, Trevor Steven, Sir | Diretor | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 40036010005 | |||||||||
| ROBINSON, Melvin Frank | Diretor | 19 Aylmer Drive HA7 3EJ Stanmore Middlesex | England | British | 146452070001 | |||||||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Diretor | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | England | British | 107002130001 | |||||||||
| SHARPE, Steven | Diretor | Kenwood House Kenwood Close NW3 7JL London | England | British | 146452160001 | |||||||||
| THOMPSON, Brian Lane | Diretor | Rock Hill House Rock Hill OX7 5BA Chipping Norton Oxfordshire | British | 56518620001 | ||||||||||
| TIMBERS, Graham Paul | Diretor | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 127888240001 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Diretor | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 17957620003 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Diretor | The Finch Inn Church Hill Finchingfield CM7 4NN Essex | United Kingdom | British | 17957620003 | |||||||||
| WPG REGISTRARS LIMITED | Diretor | Ground Floor 30 City Road EC1Y 2AB London | 106986280001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de REFINED MP LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refined Estates Limited | 06/04/2016 | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
REFINED MP LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Rental assignation | Criado em 11/01/2005 Entregue em 21/01/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and refined estates limited to the chargee | |
Breve descrição The benefit of all rents payable under the lease entered into between malthurst petroleum limited, malthurst fuels limited and malthurst UK limited dated 17 november 2003, together with such arrears (if any), including (without limitation) all vat (if any) payable on or in respect of the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 22/12/2004 Entregue em 23/12/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2005 and | Criado em 15/12/2004 Entregue em 25/01/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All and whole subjects k/a milngavie service station, glasgow road, milngavie t/n DMB4074. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 15/02/2002 Entregue em 26/02/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The property known as 457 alfreton road nottingham. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 18/07/2001 Entregue em 30/07/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Freehold property k/a little london service station london road spalding lincolnshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 22/05/2001 Entregue em 31/05/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Leasehold property being land and buildings on the south side of norwich road gillingham. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 22/05/2001 Entregue em 24/05/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee including all such monies as may fall due for payment under any agreements present and future all costs and expenses all sums due for any goods or services supplied by the chargee to the company, any interest payable to the chargee by the company, or sums which become due to the chargee in connection with any loan, and all sums which become due to the chargee in connection with an externally funded loan | |
Breve descrição Premises k/a widows cruse filling station gillinham nr beccles norfolk all fixtures and fittings not being personal chattels within the bill of sales act on the premises, all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 21/05/2001 Entregue em 30/05/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 21 june 2001 and | Criado em 18/05/2001 Entregue em 26/06/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição Milngavie service station, 42 glasgow road, milngavie. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 09/02/1996 Entregue em 28/02/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição L/H property k/a petrol filling station at junction of A143/A146 roads gillingham near beccles norfolk together with all fixtures and fittings at any tim at the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the company at the premises. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 09/02/1996 Entregue em 28/02/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição L/H property k/a petrol filling station junction A143/A146 roads gillingham nr. Beccles norfolk together with all fixtures fittings at the premises all rental income at any time all rights and claims against any third parties all goodwill full benefit of all contracts of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge and assignment | Criado em 19/01/1995 Entregue em 23/01/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Petrol filling station development site situate at the junction of A143 and A146 gillingham norfolk all and singular the mortgagor's respective rights title and interest in and to each of the development documents and the development. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Fixed and floating charge | Criado em 03/06/1994 Entregue em 10/06/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0