OFFICE ZONE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaOFFICE ZONE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02848787
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de OFFICE ZONE LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica OFFICE ZONE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de OFFICE ZONE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    OSG TRADING LIMITED11/10/200511/10/2005
    OYEZSTRAKER HOLDINGS LIMITED23/10/199823/10/1998
    STRAKER (HOLDINGS) LIMITED29/09/199329/09/1993
    REFAL 397 LIMITED27/08/199327/08/1993

    Quais são as últimas contas de OFFICE ZONE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para OFFICE ZONE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    12 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 07/07/2022

    10 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    13 páginasLIQ10

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 07/07/2021

    11 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de Unit 4 500 Purley Way Croydon Surrey CR0 4NZ para 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR em 27/07/2020

    2 páginasAD01

    Estado de situação patrimonial

    8 páginasLIQ02

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 08/07/2020

    LRESEX

    Segunda apresentação para a nomeação de Stephen James Horne como administrador

    6 páginasRP04AP01

    Nomeação de Mr Richard John Oates como diretor em 17/01/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Graham Mobbs como diretor em 17/01/2020

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/08/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Cessação de Jonathan Paul Moulton como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    1 páginasPSC07

    Notificação de Officeteam 2 Group Limited como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    2 páginasPSC02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018

    7 páginasAA

    Nomeação de Mr Stephen James Horne como diretor em 04/03/2019

    3 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    04/03/2020Clarification A second filed AP01 was registered on 04/03/2020.

    Término da nomeação de Jeffrey Michael Whiteway como diretor em 18/01/2019

    1 páginasTM01

    Registo da garantia 028487870014, criada em 23/11/2018

    60 páginasMR01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/08/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    7 páginasAA

    Satisfação total da garantia 028487870009

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 31/08/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    7 páginasAA

    Quem são os diretores de OFFICE ZONE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MAYNARD, Philippa Anne
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Secretário
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    British44140850002
    HORNE, Stephen James
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    C/0 Office Team Ltd
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    C/0 Office Team Ltd
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish256352360001
    OATES, Richard John
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    Diretor
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    United KingdomBritish198603960001
    BARHAM, Richard Edgar Charles
    58 High Road
    Loughton
    Essex
    Secretário nomeado
    58 High Road
    Loughton
    Essex
    British900007310001
    BLANCHARD, Lisa Anne
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    Secretário
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    British40576530001
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Secretário
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    British67707480001
    PARNELL, Julie Caroline
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    Secretário
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    British25488170003
    ALUN-JONES, Derek (John Derek), Sir
    The Willows
    KT24 5JE Effingham Common
    Surrey
    Diretor
    The Willows
    KT24 5JE Effingham Common
    Surrey
    British28440590001
    APPLETON, William John
    28 Bedford Avenue
    Silsoe
    MK45 4ER Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    28 Bedford Avenue
    Silsoe
    MK45 4ER Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritish55953830001
    CAHILL, Peter Charles
    Ilgars Manor Cottages
    2 Mosses Lane
    CM3 8RD South Woodham Ferrers
    Essex
    Diretor
    Ilgars Manor Cottages
    2 Mosses Lane
    CM3 8RD South Woodham Ferrers
    Essex
    British36596500003
    COX, David
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish70818680001
    DONALD, Sidney Milne
    1 Smith Barry Crescent
    Upper Rissington
    GL54 2NG Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    1 Smith Barry Crescent
    Upper Rissington
    GL54 2NG Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish64096360001
    EADES, Lisa Anne
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    Diretor
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish40576530004
    EWART SMITH, Michael
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    Diretor
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    EnglandBritish73942450001
    EWART SMITH, Michael
    The Long Cottage
    High Street, Old Bursledon
    SO31 8DL Southampton
    Hampshire
    Diretor
    The Long Cottage
    High Street, Old Bursledon
    SO31 8DL Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish73942450001
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Diretor
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    British67707480001
    HEYS, David Michael
    Woodside House
    597 Wheatley Lane Road
    BB12 9EP Burnley
    Lancashire
    Diretor
    Woodside House
    597 Wheatley Lane Road
    BB12 9EP Burnley
    Lancashire
    United KingdomBritish71032080003
    HICKFORD, John
    Gartan House 9a East Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AW Potters Bar
    Hertfordshire
    Diretor
    Gartan House 9a East Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AW Potters Bar
    Hertfordshire
    British61175600001
    HODGES, Nicholas Robin
    34 Holland Road
    MK45 2RS Ampthill
    Bedfordshire
    Diretor
    34 Holland Road
    MK45 2RS Ampthill
    Bedfordshire
    EnglandBritish48585350003
    HODGES, Nicholas Robin
    Ramsau 1 Ware Leys Close
    Marsh Gibbon
    OX6 0EN Bicester
    Oxfordshire
    Diretor
    Ramsau 1 Ware Leys Close
    Marsh Gibbon
    OX6 0EN Bicester
    Oxfordshire
    British48585350002
    LANDSBERG, Kenneth William
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    Diretor
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    British67271850002
    LAWSON, Philip Andrew
    Clayton Cottages 65 High Street
    RH9 8DT Godstone
    Surrey
    Diretor
    Clayton Cottages 65 High Street
    RH9 8DT Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish50604220003
    LENNARD, Andrew Dacre
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish68152930001
    MCCALLUM, Alexander James
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    Diretor
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    United KingdomBritish93679470001
    MOBBS, Andrew Graham
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    Diretor
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    United KingdomBritish175045450001
    MOORE, Robert James
    19 The Hazels
    ME8 0SE Gillingham
    Kent
    Diretor
    19 The Hazels
    ME8 0SE Gillingham
    Kent
    United KingdomBritish77594790001
    MORGAN, Richard James
    Parkfield 4 Somerville Road
    B73 6JA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    Parkfield 4 Somerville Road
    B73 6JA Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish15621070003
    PITT, Derek Neil
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    Diretor
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    British14385530005
    PITT, Derek Neil
    160 Shirehall Road
    DA2 7SN Hawley
    Kent
    Diretor
    160 Shirehall Road
    DA2 7SN Hawley
    Kent
    British14385530003
    RICHARDS, Benjamin William
    Highcroft
    Chilworth Road, Chilworth
    SO16 7LP Southampton
    Hampshire
    Diretor
    Highcroft
    Chilworth Road, Chilworth
    SO16 7LP Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish157483970001
    SANDARS, George Russell
    5 Crescent Road
    SW20 8EY London
    Diretor nomeado
    5 Crescent Road
    SW20 8EY London
    British900007300001
    SEAR, Hugh Edward
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    Diretor
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    EnglandEnglish47246600001
    SMITH, Graham
    The Old Vicarage Cottage
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    Diretor
    The Old Vicarage Cottage
    Atcham
    SY5 6QE Shrewsbury
    British69193860001
    STRAKER, Jonathan
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    Diretor
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    British10770260001
    WHITEWAY, Jeffrey Michael
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    Diretor
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    EnglandBritish14385570002

    Quem são as pessoas com controle significativo de OFFICE ZONE LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Mr Jonathan Paul Moulton
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    06/04/2016
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    Sim
    Nacionalidade: British
    País de residência: Guernsey
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    06/04/2016
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro03185023
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    OFFICE ZONE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 23/11/2018
    Entregue em 29/11/2018
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • BECAP12 Gp Limited as General Partner of BECAP12 Gp LP as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transações
    • 29/11/2018Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 17/07/2015
    Entregue em 20/07/2015
    Pendente
    Breve descrição
    Not applicable.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC as Receivables Purchaser, Inventory Lender and Property Lender and Lloyds Bank Commercial Finance Limited as Agent (Together "Lloyds")
    Transações
    • 20/07/2015Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 14/08/2014
    Entregue em 18/08/2014
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Becap 12 Gp Limited Acting in Its Capaciy as General Partner of BECAP12 Gp LP, Acting in Its Capacity as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transações
    • 18/08/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 28/07/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 24/07/2014
    Entregue em 08/08/2014
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • BECAP12 Gp Limited
    Transações
    • 08/08/2014Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 24/07/2014
    Entregue em 08/08/2014
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • BECAP12 Gp Limited
    Transações
    • 08/08/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 28/07/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 12/06/2013
    Entregue em 22/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 22/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 24/01/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 12/06/2013
    Entregue em 20/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transações
    • 20/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/08/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of accession
    Criado em 20/06/2007
    Entregue em 22/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The acceding company assigns, with full title guarantee by way of absolute legal assignment the contracts, intellectual property rights, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transações
    • 22/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 22/08/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating charge
    Criado em 17/04/2003
    Entregue em 23/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 23/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 31/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 03/04/2003
    Entregue em 10/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent
    Transações
    • 10/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 31/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined)
    Criado em 30/04/2001
    Entregue em 15/05/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/05/2001Registro de uma garantia (395)
    • 05/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 01/09/1997
    Entregue em 11/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Bank of Scotland Treasury Services PLC
    Transações
    • 11/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 05/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of assignment of life policies
    Criado em 01/09/1997
    Entregue em 11/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The policies and all monies including bonuses accrued re : the life policy no. 3522175, life assured hugh sear, sum assured £500,000, cover life, insurer scottish equitable.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandand Its Successors and Assigns
    Transações
    • 11/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 05/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 21/03/1995
    Entregue em 31/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 31/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 04/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    OFFICE ZONE LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    08/07/2020Início da liquidação
    12/12/2023Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Profissional
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Profissional
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Profissional
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0