HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED

HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02864153
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Qual é o status da última declaração anual para HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    3 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de Towergate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN para 92 London Street Reading Berkshire RG1 4SJ em 19/05/2015

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 05/05/2015

    LRESSP

    Término da nomeação de Mark Steven Hodges como diretor em 17/10/2014

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/10/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/10/2014

    Estado do capital em 02/10/2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    5 páginasAA

    Nomeação de Jennifer Owens como secretário

    1 páginasAP03

    Declaração anual preparada até 01/10/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital11/10/2013

    Estado do capital em 11/10/2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Término da nomeação de Samuel Clark como secretário

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    5 páginasAA

    Término da nomeação de Peter Cullum como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/10/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    5 páginasAA

    Nomeação de Mr Mark Steven Hodges como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Timothy Philip como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Scott Egan como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Scott Egan como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 01/10/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Nomeação de Mr Samuel Thomas Budgen Clark como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Andrew Hunter como secretário

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    5 páginasAA

    Nomeação de Mr Andrew Stewart Hunter como secretário

    1 páginasAP03

    Quem são os diretores de HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    OWENS, Jennifer
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Secretário
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    183297560001
    EGAN, Scott
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Diretor
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish170703910001
    ALEXANDER, Peter
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    Secretário
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    British60245740001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretário
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    153023140001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretário
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    161872300001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretário
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    British76055420004
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Secretário
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    British99424380001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretário
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    156617460001
    LYONS, Derek George William
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    Secretário
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    Irish20310970001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Secretário
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretário nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Diretor
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    British60697560014
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Diretor
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish140488120001
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Diretor
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritish99424380001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Diretor
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United KingdomBritish58444370003
    LYONS, Derek George William
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    Diretor
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    EnglandIrish20310970001
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Diretor
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    EnglandAustralian99066410002
    PROVERBS, Antony
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Diretor
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    EnglandBritish79185700013
    SHARP, Brian Stephen
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Diretor
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    British18202060001
    SHARP, Jean Marie
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Diretor
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    British18202050001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Diretor nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 31/08/2001
    Entregue em 13/09/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Breve descrição
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 13/09/2001Registro de uma garantia (395)
    • 10/11/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Criado em 31/03/2000
    Entregue em 07/04/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank, the Hedging Bank and the Investor (All as Defined)
    Transações
    • 07/04/2000Registro de uma garantia (395)
    • 10/11/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    05/05/2015Início da liquidação
    24/11/2015Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    David William Tann
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profissional
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profissional
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0