TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02866179
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ACDTRIDON EUROPE LIMITED29/05/199629/05/1996
    AUTOMOTIVE COMPONENTS DUNSTABLE LIMITED14/12/199314/12/1993
    PIRGOS LIMITED26/10/199326/10/1993

    Quais são as últimas contas de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Qual é o status da última declaração anual para TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginas4.71

    Término da nomeação de Coral Suzanne Bidel como diretor em 22/10/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Daniel Marc Richard Jaffe como diretor em 09/07/2015

    2 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU para Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY em 12/12/2014

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resolução de insolvência

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 26/11/2014

    LRESSP

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Declaração anual preparada até 01/12/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/12/2014

    Estado do capital em 09/12/2014

    • Capital: GBP 22,903,734
    SH01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 10/10/2014

    • Capital: GBP 22,903,734
    3 páginasSH01

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    12 páginasAA

    Término da nomeação de Nicolas Paul Wilkinson como diretor em 30/09/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Thomas C. Reeve como diretor em 30/09/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Elizabeth Honor Lewzey como diretor em 30/09/2014

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Miss Coral Bidel em 05/09/2014

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr Daniel Marc Richard Jaffe como diretor em 13/08/2014

    2 páginasAP01

    Nomeação de Intertrust (Uk) Limited como secretário em 13/08/2014

    2 páginasAP04

    Nomeação de Miss Coral Bidel como diretor em 13/08/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Elizabeth Honor Lewzey como secretário em 13/08/2014

    1 páginasTM02

    Endereço do domicílio registado alterado de Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE para 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU em 22/08/2014

    1 páginasAD01

    Satisfação total da garantia 4

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 01/12/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/12/2013

    Estado do capital em 10/12/2013

    • Capital: GBP 18,010,000
    SH01

    Quem são os diretores de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Secretário
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro06307550
    188126550001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Secretário
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157101930001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Secretário
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833360001
    SHORTT, Eugene
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    Secretário
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    British4764420001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Secretário
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Secretário nomeado
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    ABBOTT, Brian Arthur
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    Diretor
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish38296100001
    BIDEL, Coral Suzanne
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Diretor
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish179297460002
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Diretor
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    CAREY, Stephen James
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    British76189900002
    CORPATAUX, Beat Eugene
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    Diretor
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss49248640001
    DRUMMOND, David Fraser
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    Diretor
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    British43960000001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Diretor
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HILLSON, Anthony Leonard
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    Diretor
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    British43960090001
    HOFMANN, Helmut
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Diretor
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Canadian46601750001
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Diretor
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOTTINGER, Michael
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    Diretor
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    American46550450001
    JAFFE, Daniel Marc Richard
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Diretor
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish140811810001
    KEECH, Craig William
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    Diretor
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    British45367870003
    KEECH, Dennis
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    Diretor
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritish24425650001
    KEECH, Matthew David
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    Diretor
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    British38296150001
    KINGSBURGH, Murray
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Diretor
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Canadian46550570001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LEE, Norman Holt
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    Diretor
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    British38296170001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Diretor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MUSHTAQ, Mohammed Arif
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    Diretor
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    British42865020001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Diretor
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    REEVE, Thomas C.
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    Diretor
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    United StatesAmerican161822390001
    RENNER, James
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Diretor
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Canadian46550730001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Diretor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish48808690001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Diretor
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Diretor nomeado
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001

    TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A security agreement
    Criado em 30/09/2010
    Entregue em 15/10/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust Fsb (The Collateral Agent)
    Transações
    • 15/10/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/01/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 30/09/2010
    Entregue em 13/10/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Usa, Inc. (The Collateral Agent)
    Transações
    • 13/10/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/01/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of composite guarantee and debenture
    Criado em 08/02/1996
    Entregue em 23/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed
    Breve descrição
    All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Bank of Nova Scotia
    Transações
    • 23/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 03/12/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 08/02/1994
    Entregue em 16/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 16/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 09/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage and specific charge
    Criado em 08/02/1994
    Entregue em 16/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 16/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 05/02/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/11/2014Início da liquidação
    23/02/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Profissional
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0