INEXUS (SERVICES) LIMITED

INEXUS (SERVICES) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINEXUS (SERVICES) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02875320
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INEXUS (SERVICES) LIMITED?

    • Atividades de consultoria de gestão, exceto gestão financeira (70229) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica INEXUS (SERVICES) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Synergy House Windmill Avenue
    Woolpit
    IP30 9UP Bury St. Edmunds
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de INEXUS (SERVICES) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CONNECT UTILITIES LIMITED13/08/200113/08/2001
    TOTALFINAELF CONNECT LIMITED22/08/200022/08/2000
    ELF CONNECT LIMITED17/06/199917/06/1999
    GAS TECHNOLOGY LIMITED08/12/199308/12/1993
    SEAGAS CONSULTANTS LIMITED26/11/199326/11/1993

    Quais são as últimas contas de INEXUS (SERVICES) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para INEXUS (SERVICES) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01
    A91GJ2E3

    Declaração de confirmação apresentada em 26/11/2019 com atualizações

    4 páginasCS01
    X8J28C8O

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2018 para 30/06/2019

    1 páginasAA01
    X8EPN8FV

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Company Secretary Energy House Woolpit Business Park, Windmill Avenue Woolpit Bury St. Edmunds Suffolk IP30 9UP para Synergy House Windmill Avenue Woolpit Bury St. Edmunds IP30 9UP em 19/06/2019

    1 páginasAD01
    X87YFJSG

    legacy

    1 páginasSH20
    L7K9YKUW

    Estado do capital em 07/12/2018

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19
    L7K9YKU8

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    L7K9YKUO

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account 07/12/2018
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 26/11/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X7JJLDNN

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    19 páginasAA
    A7EA0ATU

    Declaração de confirmação apresentada em 26/11/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X6K38T63

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    18 páginasAA
    A6ESRAJE

    Declaração de confirmação apresentada em 26/11/2016 com atualizações

    5 páginasCS01
    X5KR7Z6O

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    19 páginasAA
    A5BRR1TM

    Declaração anual preparada até 26/11/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital26/11/2015

    Estado do capital em 26/11/2015

    • Capital: GBP 1,299
    SH01
    X4L0QX0J

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    14 páginasAA
    A4FXSTM1

    Declaração anual preparada até 26/11/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/12/2014

    Estado do capital em 01/12/2014

    • Capital: GBP 1,299
    SH01
    X3LUM0PS

    Detalhes do diretor alterados para Mr Darryl John Corney em 01/01/2014

    2 páginasCH01
    X3LUM0PK

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    14 páginasAA
    A3HI1UO2

    Detalhes do diretor alterados para Mr Clive Eric Linsdell em 23/10/2013

    2 páginasCH01
    X2YZ60V5

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD
    A2MZX1HV

    Declaração anual preparada até 26/11/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital29/11/2013

    Estado do capital em 29/11/2013

    • Capital: GBP 1,299
    SH01
    X2M6W6D4

    Nomeação de Mr Clive Eric Linsdell como diretor

    2 páginasAP01
    X2ES7A5V

    Quem são os diretores de INEXUS (SERVICES) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MUMFORD, Christopher Paul
    Ellen Street
    CF10 4BP Cardiff
    Driscoll 2
    United Kingdom
    Secretário
    Ellen Street
    CF10 4BP Cardiff
    Driscoll 2
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary77633500001
    CORNEY, Darryl John
    Windmill Avenue
    Woolpit
    IP30 9UP Bury St. Edmunds
    Synergy House
    England
    Diretor
    Windmill Avenue
    Woolpit
    IP30 9UP Bury St. Edmunds
    Synergy House
    England
    EnglandBritishDirector83564940010
    LINSDELL, Clive Eric
    Windmill Avenue
    Woolpit
    IP30 9UP Bury St. Edmunds
    Synergy House
    England
    Diretor
    Windmill Avenue
    Woolpit
    IP30 9UP Bury St. Edmunds
    Synergy House
    England
    United KingdomBritishCompany Director175552240002
    CASTLE, Rodney Grahame
    The Old Cottage
    Wells Lane
    GU3 2BS Guildford
    Surrey
    Secretário
    The Old Cottage
    Wells Lane
    GU3 2BS Guildford
    Surrey
    British4150130002
    CLEMENTS, Anthony Alfred
    208 Gladstone Road
    CF62 8ND Barry
    South Glamorgan
    Secretário
    208 Gladstone Road
    CF62 8ND Barry
    South Glamorgan
    BritishChartered Engineer37218980001
    JONES, Brian Richard
    Dando Castle Hill
    Llanblethian
    CF7 7JN Cowbridge
    South Glamorgan
    Secretário
    Dando Castle Hill
    Llanblethian
    CF7 7JN Cowbridge
    South Glamorgan
    British44056050001
    MAHER, Abdul Majid
    Springstones
    Trerhyngyll Road Maendy
    CF71 7TG Cowbridge
    South Glamorgan
    Secretário
    Springstones
    Trerhyngyll Road Maendy
    CF71 7TG Cowbridge
    South Glamorgan
    British46158890001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretário nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ADDISON SMYTH, Gregory Martin
    11 Llys Steffan
    CF61 2UF Llantwit Major
    Vale Of Glamorgan
    Diretor
    11 Llys Steffan
    CF61 2UF Llantwit Major
    Vale Of Glamorgan
    BritishElectrical Networks Director103339120001
    CLEMENTS, Anthony Alfred
    208 Gladstone Road
    CF62 8ND Barry
    South Glamorgan
    Diretor
    208 Gladstone Road
    CF62 8ND Barry
    South Glamorgan
    BritishChartered Engineer37218980001
    EVANS, John Winston
    9 Hazel Grove
    CF64 4TE Dinas Powys
    South Glamorgan
    Diretor
    9 Hazel Grove
    CF64 4TE Dinas Powys
    South Glamorgan
    BritishChartered Engineer37218990001
    GIBB, Philip
    The Sages
    Colwinston
    CF71 7NL Cardiff
    Diretor
    The Sages
    Colwinston
    CF71 7NL Cardiff
    BritishDirector104195320001
    GOUGH, David
    Orchard House
    No 1 Acorn Close
    NP4 7UU Abersychan
    Gwent
    Diretor
    Orchard House
    No 1 Acorn Close
    NP4 7UU Abersychan
    Gwent
    BritishConstruction Director83436070001
    HINCHLIFFE, John William
    1 The Mount
    Graig Road Lisvane
    CF14 0FJ Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    1 The Mount
    Graig Road Lisvane
    CF14 0FJ Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritishCompany Director58990880001
    JENKINS, Graham John
    Stanwardine House
    Stanwardine In The Wood Cockshutt
    SY12 0JL Ellesmere
    Diretor
    Stanwardine House
    Stanwardine In The Wood Cockshutt
    SY12 0JL Ellesmere
    United KingdomBritishDevelopment Director77477400001
    KITSON, Peter John
    32 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    32 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Berkshire
    BritishAccountant40765310001
    LAFOND, Jacques
    18 Rue De L`Assomption
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    Diretor
    18 Rue De L`Assomption
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    FrenchBusiness Manager69395100001
    LEGROS, Didier
    20 Farriers Walk
    234 Fulham Road
    SW10 9FW London
    Diretor
    20 Farriers Walk
    234 Fulham Road
    SW10 9FW London
    FrenchGeneral Manager73864110002
    MARSHALL, Alan Roger
    Flat 128 Crown Lodge
    12 Elystan Street
    SW3 3PW London
    Diretor
    Flat 128 Crown Lodge
    12 Elystan Street
    SW3 3PW London
    BritainBritishDirector56337710001
    MATTHEWS, Kenneth
    4 Springfield Close
    CF5 6DA Wenvoe
    South Glamorgan
    Diretor
    4 Springfield Close
    CF5 6DA Wenvoe
    South Glamorgan
    BritishChartered Gas Engineer110815410001
    NICHOLLS, Peter Harrison
    Warrenfield
    Bengeo Street
    SG14 3ES Hertford
    Hertfordshire
    Diretor
    Warrenfield
    Bengeo Street
    SG14 3ES Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritishSenior Vp Gas & Electricity14348610001
    PEARCE, Michael William
    HR3 6BA Dorstone
    Sydcombe Farm
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    HR3 6BA Dorstone
    Sydcombe Farm
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector77521670011
    WARD, Russell Adrian Edmund
    Belmont Lodge
    Catsash Road Christchurch
    NP18 1LB Newport
    Diretor
    Belmont Lodge
    Catsash Road Christchurch
    NP18 1LB Newport
    WalesBritishCompany Director148320100001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Quem são as pessoas com controle significativo de INEXUS (SERVICES) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Inexus Group (Holdings) Limited
    Woolpit Business Park, Windmill Avenue
    Woolpit
    IP30 9UP Bury St. Edmunds
    Energy House
    Suffolk
    England
    06/04/2016
    Woolpit Business Park, Windmill Avenue
    Woolpit
    IP30 9UP Bury St. Edmunds
    Energy House
    Suffolk
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro04222730
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    INEXUS (SERVICES) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating security document
    Criado em 12/11/2012
    Entregue em 22/11/2012
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transações
    • 22/11/2012Registro de uma garantia (MG01)
    Rent deposit deed
    Criado em 02/01/2008
    Entregue em 22/07/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The interest in a deposit account opened in accordance with the rent deposit deed in relation to charnwood house ocean way ocean park cardiff see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Charnwood Holdings Limited
    Transações
    • 22/07/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 19/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating security document
    Criado em 04/10/2005
    Entregue em 20/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Payment of all liabilities,first legal mortgage all real property in england and wales,first fixed equitable charge,all other real property belonging to the company,first fixed charge all its present and future bank accounts,investments,uncalled capital and goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transações
    • 20/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating security document
    Criado em 31/08/2005
    Entregue em 07/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All real property bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property floating charge its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as the Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transações
    • 07/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Guarantee and debenture between the company (formerly known as totalfinaelf connect limited) and the royal bank of scotland PLC
    Criado em 08/08/2001
    Entregue em 21/08/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys,liabilities and other obligations due or to become due from any of the obligors (as defined) to all or any of the secured parties (as defined) under the financing documents (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 21/08/2001Registro de uma garantia (395)
    • 15/02/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 05/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0