LEASING DECEMBER (14) LIMITED

LEASING DECEMBER (14) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLEASING DECEMBER (14) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02876243
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    • Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Oak Green House, 250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Surrey
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DRESDNER KLEINWORT LEASING DECEMBER (14) LIMITED18/09/200618/09/2006
    ABBEY NATIONAL SEPTEMBER LEASING (6) LTD23/12/199323/12/1993
    ALLREJECT COMPANY LIMITED29/11/199329/11/1993

    Quais são as últimas contas de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2022

    Quais são as últimas submissões para LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2022

    9 páginasAA

    Término da nomeação de Jonathon Paul Sowton como diretor em 30/06/2023

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Martin John Sockett como diretor em 27/06/2023

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2021

    10 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2020

    9 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Grafton Group Secretarial Services Limited em 31/12/2020

    2 páginasCH04

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2019

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2018

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2017

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2016

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    10 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    9 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/01/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/01/2016

    Estado do capital em 04/01/2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomeação de Brian O'hara como diretor em 07/05/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Brian Hodgkiss como diretor em 30/04/2015

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Heron House
    Corrig Road Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Co/Grafton Group Plc
    Ireland
    Secretário
    Heron House
    Corrig Road Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Co/Grafton Group Plc
    Ireland
    Forma jurídicaPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
    Tipo de identificaçãoOutra pessoa coletiva ou firma
    Autoridade legalIRISH COMPANIES ACT 2014
    Número de registro243716
    97259990001
    O'HARA, Brian
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Diretor
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish189958690001
    SOCKETT, Martin John, Mr.
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6LW Birmingham
    Ground Floor, Boundary House
    England
    Diretor
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6LW Birmingham
    Ground Floor, Boundary House
    England
    EnglandBritish291426940001
    DANIEL, Irina Marsovna
    Flat 1
    9 Cromwell Place
    SW7 2JN London
    Secretário
    Flat 1
    9 Cromwell Place
    SW7 2JN London
    British113609450004
    LONGCROFT, Peter Leonard
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    Secretário
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    British32431030003
    STEVENS, Andrew John
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    Secretário
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    British103050090001
    WALL, James Cameron
    95 Willow Park
    Otford
    TN14 5NF Sevenoaks
    Kent
    Secretário
    95 Willow Park
    Otford
    TN14 5NF Sevenoaks
    Kent
    British11724060005
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey House Baker Street
    Baker Street
    NW1 6XL London
    Secretário
    Abbey House Baker Street
    Baker Street
    NW1 6XL London
    61749570001
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretário
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AIKEN, Neil Gordon
    The Birches 14 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    Diretor
    The Birches 14 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish43380390001
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Diretor
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    British34184100001
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Diretor
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    British34184100001
    BIRCH, Richard Alastair
    61 Fishpool Street
    AL3 4RU St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    61 Fishpool Street
    AL3 4RU St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish152524800001
    COHEN, Jonathan Paul
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    Diretor
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    EnglandBritish26953400001
    EDWARDS, Shirley Ann Elizabeth
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    Diretor
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    British61855020002
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Diretor
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    FANE DE SALIS, Henrietta Frances Jane
    52 Colebrooke Row
    N1 8AF London
    Diretor
    52 Colebrooke Row
    N1 8AF London
    British100519650004
    GARRATT, Robin
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    Diretor
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    EnglandBritish14290340001
    GREEN, David Martin
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    Diretor
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    British83033800001
    HODGKISS, Brian
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish37164140002
    HUTCHISON, Sarah Anne
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    Diretor
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    British36372610001
    JONES, David Gareth
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    Diretor
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish6205890002
    JULIAN, Suzanne Margaret
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    Diretor
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    British36432460001
    LEVY, Anthony David
    59 Daneland
    EN4 8PZ East Barnet
    Hertfordshire
    Diretor
    59 Daneland
    EN4 8PZ East Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish98888430001
    LONG, Graham Stephen
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    Diretor
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    British38022070005
    LOWE, William Nairn
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    Diretor
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    EnglandBritish282371920001
    MERRICK, Anna
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    Diretor
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    British39621110002
    MIDDLETON, Kevin Paul
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    Diretor
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    EnglandBritish61374610002
    NICHOLLS, Jonathan Clive
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    Diretor
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    United KingdomEnglish127532290001
    O'DONOVAN, Colin
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Diretor
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish164508820001
    O'NUALLAIN, Colm
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Diretor
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish79602480001
    PARES, Michael
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    Diretor
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    EnglandBritish21670040001
    SOWTON, Jonathon Paul
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish151407670001

    Quem são as pessoas com controle significativo de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Grafton Group (Uk) Plc
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    06/04/2016
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland & Wales
    Número de registro02886378
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    LEASING DECEMBER (14) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Lease security assignment
    Criado em 26/09/2007
    Entregue em 04/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Assign absolutely and unconditionally the rental property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transações
    • 04/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge over bank account
    Criado em 26/09/2007
    Entregue em 04/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All present and future right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transações
    • 04/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Lease security assignment
    Criado em 26/09/2007
    Entregue em 04/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Assign absolutely and unconditionally the rental property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transações
    • 04/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge over bank account
    Criado em 26/09/2007
    Entregue em 04/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transações
    • 04/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Headlease security assignment
    Criado em 26/09/2007
    Entregue em 04/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Assign absolutely and unconditionally the headlease property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transações
    • 04/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge over bank account
    Criado em 26/09/2007
    Entregue em 04/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transações
    • 04/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 27/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0