TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED

TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02876730
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    INTERNET RECRUITMENT GROUP LIMITED08/01/199808/01/1998
    INTERNET CONTRACT SERVICES LIMITED01/12/199301/12/1993

    Quais são as últimas contas de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/01/2016

    Quais são as últimas submissões para TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Satisfação total da garantia 3

    2 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 4

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 2

    2 páginasMR04

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 30/10/2017

    • Capital: GBP 2
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Cancellation of the share premium account 27/10/2017
    RES13

    Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Notificação de Harvey Nash Group Plc como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    1 páginasPSC02

    Nomeação de Mark Jonathan Garratt como diretor em 27/04/2017

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mark Jonathan Garratt como secretário em 27/04/2017

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Jonathan Richard Ashcroft como diretor em 27/04/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jonathan Richard Ashcroft como secretário em 27/04/2017

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/01/2016

    16 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/06/2016 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/07/2016

    Estado do capital em 04/07/2016

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/01/2015

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/11/2015 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/11/2015

    Estado do capital em 02/11/2015

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Declaração anual preparada até 01/11/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/12/2014

    Estado do capital em 24/12/2014

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/01/2014

    16 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de Harvey Nash Heron Tower 110 Bishopsgate London England and Wales EC2N 4AY para 110 Bishopsgate London EC2N 4AY em 22/09/2014

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 01/11/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/11/2013

    Estado do capital em 08/11/2013

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/01/2013

    13 páginasAA

    Quem são os diretores de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Secretário
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    231362320001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director49452080003
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Diretor
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector229682100001
    WASSALL, Simon Mark
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    Diretor
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector108449780001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretário
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British258414370001
    BROADFOOT, Victoria Louise
    8 Aigburth Mansions
    Mowll Street Vauxhall
    SW9 0EP London
    Secretário
    8 Aigburth Mansions
    Mowll Street Vauxhall
    SW9 0EP London
    British56121450002
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secretário
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director49452080003
    LINCOLN, Simon Paul
    94 Fentiman Road
    Vauxhall
    SW8 1LA London
    Secretário
    94 Fentiman Road
    Vauxhall
    SW8 1LA London
    BritishSalesman37131030001
    STEVENS, Paul John
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    Secretário
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    British36606580005
    WEST, Ashley Brendon George
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    Secretário
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    BritishAccountant58376020002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretário nomeado
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director258414370001
    BEEKE, Paul Lincoln
    Apartment 9n
    New York
    Ny 10013
    U S A
    Diretor
    Apartment 9n
    New York
    Ny 10013
    U S A
    BritishManagement Consultant60439120004
    CRAWFORD, Thomas Francis Alexander
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    Diretor
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    United KingdomBritishCompany Director3856480002
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Diretor
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director81663830001
    GOODMAN, Andrew Graham
    The Pound House
    46 Totteridge Village
    N20 8PR London
    Diretor
    The Pound House
    46 Totteridge Village
    N20 8PR London
    United KingdomBritishConsultant57773080002
    HEATH, James Edward
    87 Langham Road
    TW11 9HG Teddington
    Middlesex
    Diretor
    87 Langham Road
    TW11 9HG Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1329740003
    HIGGINS, David Charles
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    Diretor
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    United KingdomBritishCompany Director33333910003
    STEVENS, Paul John
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    Diretor
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    EnglandBritishRecruitment Consultant36606580005
    TICE, Trevor Anthony
    1364 Union Street C
    San Francisco Ca 94109
    Usa
    Diretor
    1364 Union Street C
    San Francisco Ca 94109
    Usa
    AmericanManagement Consultant61254610001
    WEST, Ashley Brendon George
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    BritishAccountant58376020002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Diretor nomeado
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Quem são as pessoas com controle significativo de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    06/04/2016
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3320790
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 05/06/2002
    Entregue em 13/06/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 13/06/2002Registro de uma garantia (395)
    • 04/01/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 24/03/2000
    Entregue em 31/03/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Barclays bank PLC re techpartners international limited business premium account number 00453471 and barclays bank PLC re techpartners international limited barclays united states dollar deposit account number 49916766. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 31/03/2000Registro de uma garantia (395)
    • 04/01/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Criado em 16/11/1998
    Entregue em 25/11/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed equitable charge over all debts purchased pursuant to the agreement with all related rights thereto and all amounts of indebtedness owing or becoming due to the company; floating charge over monies received in respect of the debts.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 25/11/1998Registro de uma garantia (395)
    • 04/01/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 12/04/1994
    Entregue em 13/04/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future and a floating charge on all book debts and other debts.
    Pessoas com direito
    • Close Invoice Finance Limited
    Transações
    • 13/04/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/08/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0