TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02891007
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    10 Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    Kent
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED18/11/200518/11/2005
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP PLC18/02/200418/02/2004
    ATTENTIV SYSTEMS GROUP LIMITED14/01/200414/01/2004
    LYNX GROUP LIMITED06/06/200206/06/2002
    LYNX FINANCIAL SYSTEMS (RETAIL BANKING) LIMITED13/07/199813/07/1998
    QUADRA COMPUTER SERVICES LIMITED07/03/199407/03/1994
    QUADRA LIMITED25/01/199425/01/1994

    Quais são as últimas contas de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 25/01/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital05/02/2013

    Estado do capital em 05/02/2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Janne Kaarlo Salminen em 23/02/2012

    4 páginasCH01

    Término da nomeação de Paul Jameson como secretário em 24/02/2012

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Paul Richard Jameson como diretor em 24/02/2012

    2 páginasTM01

    Nomeação de Nigel Anthony Ernest Brown como diretor em 23/02/2012

    3 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de Ground Floor, the Arenson Centre Arenson Way Houghton Regis Dunstable Bedfordshire LU5 5UL United Kingdom em 24/02/2012

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 25/01/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    13 páginasAA

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    14 páginasAA

    Término da nomeação de Ari Peltonen como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Janne Kaarlo Salminen como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 25/01/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Paul Richard Jameson em 18/02/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Ari Petteri Peltonen em 18/02/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Paul Jameson em 18/02/2011

    1 páginasCH03

    Estado do capital em 14/01/2011

    • Capital: GBP 100
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Reduce share prem to nil 07/01/2011
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Endereço do domicílio registado alterado de Gainsborough House Houghton Hall Park Houghton Regis Bedfordshire LU5 5XF em 10/05/2010

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2009

    14 páginasAA

    Quem são os diretores de TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BROWN, Nigel Anthony Ernest
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    Diretor
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United KingdomBritish64884990001
    SALMINEN, Janne Kaarlo
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    FinlandFinnish161336610001
    FAIRCLOUGH, Ian Peter
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretário
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    British55444950001
    JAMESON, Paul
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    British108959640001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretário
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    British62567380001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Secretário
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    British71468530002
    SINNETT, Paul Martin
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    Secretário
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    British71468530001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Secretário
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    British72282230002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Diretor
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritish52852920002
    COUZENS, Michael Reginald Joseph
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    11 Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    British91121570002
    DOUGLAS MANN, Stewart Charles Hamilton
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Diretor
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    EnglandBritish46258180001
    FISHER, Linda Jean
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    5 Priory Orchard
    Flamstead
    AL3 8BU St Albans
    Hertfordshire
    British37491520001
    HOLMEN, Knut
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    Diretor
    Dagalivn. 25b
    No-0776 Oslo
    Norway
    Norwegian129202940001
    HONE, Michael Frank
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    Diretor
    3 Coniston Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PY Dronfield
    Derbyshire
    British37491510002
    JACKLIN, Ian Charles
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    37 Brookhouse Hill
    Fulwood
    S10 3TB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish37491500001
    JAMESON, Paul Richard
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4LT West Malling
    10
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish109810380001
    KERNAHAN, Adrian Clive
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    10 Medlows
    AL5 3AY Harpenden
    Hertfordshire
    British29600080004
    LAST, Richard
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Diretor
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish80537570001
    LINDGREN, Peter
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    Diretor
    Drakskeppsragen 55
    Taby
    Se-18363
    Sweden
    Swedish106852790001
    LISCOMBE, David Kenneth
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    Diretor
    Pear Tree Farm Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    British6387640001
    LUUPPALA, Harri Pentti Kalervo
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    Diretor
    Hakatie 15
    FOREIGN Tampere
    Fi-33880
    Finland
    Finnish106853820001
    MILNER, Andrew
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    12 Park Lane
    Upper Cumberworth
    HD8 8NP Huddersfield
    West Yorkshire
    British62567380001
    PELTOLA, Veli Erik
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    Diretor
    Alberganesplanadi 9a5
    FOREIGN Espoo
    Fi-02600
    Finland
    Finnish106852630001
    PELTONEN, Ari Petteri
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Arenson Way
    Houghton Regis
    LU5 5UL Dunstable
    Ground Floor, The Arenson Centre
    Bedfordshire
    United Kingdom
    FinlandFinnish139265650001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Diretor
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    EnglandBritish71468530002
    WEBBER, David Paul, Mr.
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Diretor
    12 Rotten Row
    Great Brickhill
    MK17 9BA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British47915530002
    WILLIAMS, David
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    Diretor
    2 Seven Stiles Drive
    Marple
    SK6 6LT Stockport
    Cheshire
    British57223140001
    WOOD, Philip Basil
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    Diretor
    Portelet
    High Street Croydon
    SG8 0DR Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish72282230002
    WYETH, David, Dr
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    British4060250001

    TIETOENATOR ATTENTIV SYSTEMS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Accession deed
    Criado em 25/06/2002
    Entregue em 03/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the dnb finance parties and/or the suk finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Skandia UK Limited (As "Security Agent")
    Transações
    • 03/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 08/04/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Criado em 02/03/1994
    Entregue em 08/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge upon the trade names "BS5" and "summit" floating charges upon all other the undertaking and all other property and assets of the company both present and future; any property and assets of the company both present and future by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 08/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 14/11/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 02/03/1994
    Entregue em 08/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 08/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 14/11/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 08/02/1994
    Entregue em 16/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 03/07/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0