TOP TEN HOLDINGS PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTOP TEN HOLDINGS PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 02891251
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Endereço do escritório registrado
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    XS LEISURE PLC14/06/199914/06/1999
    SANCTUARY LEISURE PLC20/01/199420/01/1994

    Quais são as últimas contas de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2013

    Quais são as últimas submissões para TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    33 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2022

    30 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de 4 Hardman Square Spinningfields Manchester para 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB em 15/11/2021

    2 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2021

    32 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2020

    28 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2019

    30 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2018

    38 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2017

    38 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2016

    33 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 02/07/2015

    23 páginas4.68

    Despacho judicial de insolvência

    Court order insolvency:re ian corfield ceasing to hold office as liquidator
    12 páginasLIQ MISC OC

    Notificação de cessação de atividade como liquidatário voluntário

    1 páginas4.40

    Endereço do domicílio registado alterado de Unit 8 Verulam Industrial Estate London Road St Albans Hertfordshire AL1 1JF para 4 Hardman Square Spinningfields Manchester em 22/07/2014

    2 páginasAD01

    Estado de situação patrimonial com formulário em anexo 4.19

    17 páginas4.20

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 03/07/2014

    LRESEX

    Término da nomeação de um diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Alan Weston como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de John Kerr como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Allen Walsh como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Gary Bennett como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Gary Bennett como secretário

    1 páginasTM02

    Detalhes do diretor alterados para Alan Harry Weston em 12/02/2014

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 20/01/2014 com lista global de acionistas

    18 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/02/2014

    Estado do capital em 18/02/2014

    • Capital: GBP 5,101,121.4
    SH01

    Quem são os diretores de TOP TEN HOLDINGS PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ARIS, Paul
    81 Flora Thompson Drive
    MK16 8SR Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Secretário
    81 Flora Thompson Drive
    MK16 8SR Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British43131730001
    BENNETT, Gary Roger
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    British105612540002
    BUNT, Philip Alan
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    Secretário
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    BritishCompany Secretary33027500001
    ROSENBERG, Anthony
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    Secretário
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    BritishDirector98819810001
    WESTON, Alan Harry
    72 Hillside Gardens
    HA8 8HD Edgware
    Middlesex
    Secretário
    72 Hillside Gardens
    HA8 8HD Edgware
    Middlesex
    BritishChartered Accountant48545280003
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secretário
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretário nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BENNETT, Gary Roger
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant105612540002
    BROCKLEBANK, Aubrey Thomas, Sir
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Gb-GbnBritishCompany Director56733000005
    BUNT, Philip Alan
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    Diretor
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    United KingdomBritishChartered Accountant33027500001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    Diretor
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director21686380003
    JAY, Peter Harry
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Diretor
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United KingdomBritishSolicitor34963720001
    KERR, John Graham
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director91841230002
    MACDONALD, David
    30 Sycamore Close
    Burbage
    LE10 2JU Hinckley
    Leicestershire
    Diretor
    30 Sycamore Close
    Burbage
    LE10 2JU Hinckley
    Leicestershire
    BritishOperations Director58279490001
    ROBERTS, Philip Bruce
    1 Fairfield Road
    Drury
    CH7 3EE Buckley
    Clwyd
    Diretor
    1 Fairfield Road
    Drury
    CH7 3EE Buckley
    Clwyd
    BritishCompany Director13669690001
    ROSENBERG, Anthony
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    Diretor
    Horsewalk Cottage
    Akeley Road Lillingstone
    MK18 5BF Lovell
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director98819810001
    ROSENBERG HURST, Kathryn Macia
    Yewhurst
    Chorleywood
    WD3 4ER Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    Yewhurst
    Chorleywood
    WD3 4ER Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishMarketing Director38207730001
    SIMONS, Richard Ivan
    Flat 1 66 Maresfield Gardens
    Hampstead
    NW3 5TD London
    Diretor
    Flat 1 66 Maresfield Gardens
    Hampstead
    NW3 5TD London
    United KingdomBritishDirector7157150002
    WALSH, Allen Richard
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    United Kingdom BritishDirector96098180001
    WESTON, Alan Harry
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Unit 8 Verulam Industrial Estate
    London Road
    AL1 1JF St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant48545280004
    WESTON, Ivan
    Little Court Cottage Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    Diretor
    Little Court Cottage Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    BritishDirector2263350001
    WESTON, Samuel Norman
    Wellers Mead
    Old Mill Road
    UB9 5AS Denham
    Buckinghamshire
    Diretor
    Wellers Mead
    Old Mill Road
    UB9 5AS Denham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishManaging Director12413340001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Diretor nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TOP TEN HOLDINGS PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Assignment
    Criado em 15/08/2006
    Entregue em 19/08/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All of its rights titles benefits and interests in and to the share purchase agreement and the tax deed. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/08/2006Registro de uma garantia (395)
    Assignment
    Criado em 20/01/2006
    Entregue em 24/01/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the rights,titles,benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary,contractual or otherwise under or arising out of or evidenced by a share purchase agreement dated 22ND decmeber 2005. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 24/01/2006Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 16/07/2003
    Entregue em 18/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    24/26 chapel street camborne cornwall t/n CL93666. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 18/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 23/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 23/12/2002
    Entregue em 31/12/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 31/12/2002Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 07/08/2001
    Entregue em 11/08/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Planned Amusements Limited
    Transações
    • 11/08/2001Registro de uma garantia (395)
    • 19/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 18/07/2000
    Entregue em 04/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/08/2000Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/2000Nomeação de um administrador ou gerente (405 (1))
    • 31/05/2002Notificação de cessação de atividade como administrador ou gerente (405 (2))
    • 19/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
      • Número do processo 1
    Debenture
    Criado em 18/07/2000
    Entregue em 22/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 2.2 of a supplemental agreement dated 18TH july 2000 and this debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Allied Leisure PLC
    Transações
    • 22/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 19/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/03/1998
    Entregue em 18/04/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a business acquisition agreement dated 6TH december 1997 and this deed
    Breve descrição
    Various properties as specified in the schedule to the form 395 all buildings fixtures fixed plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Allied Leisure PLC
    Transações
    • 18/04/1998Registro de uma garantia (395)
    • 19/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/03/1998
    Entregue em 08/04/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H 75 to 79 high street and 76 to 81 king street dudley T.n WM438702 f/h the dean snooker and bowls centre foxes bridge road cinderford t/n GR87850 F.h billericay transport depot radford way mountnessing t/n EX346834. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The British Linen Bank Limited
    Transações
    • 08/04/1998Registro de uma garantia (395)
    • 19/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    TOP TEN HOLDINGS PLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    18/07/2000Data do instrumento
    Administrador judicial nomeado
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Christopher Kim Rayment
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    Profissional
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    Michael Oldham
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1M 9JA 78 Hatton Garden
    London
    Profissional
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1M 9JA 78 Hatton Garden
    London
    Bryan Jackson
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    Profissional
    Pannell Kerr Forster
    New Garden House
    EC1N 8JA 78 Hatton Garden
    London
    2
    DataTipo
    15/06/2001Data da reunião para aprovar o CVA
    06/08/2003Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Lee Antony Manning
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    Profissional
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    Gary Peter Squires
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    Profissional
    Kroll Buchler Phillips
    84 Grosvenor Street
    W1K 3LN London
    3
    DataTipo
    03/07/2014Início da liquidação
    26/08/2023Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profissional
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profissional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0