EPOK LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaEPOK LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02926129
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de EPOK LIMITED?

    • (9999) /

    Onde fica EPOK LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Cable Drive
    Walsall
    WS2 7BN
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de EPOK LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ONSITE SOUTH EAST LIMITED22/10/199922/10/1999
    EPOK LIMITED05/05/199405/05/1994

    Quais são as últimas contas de EPOK LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2010

    Quais são as últimas submissões para EPOK LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Jonathan Bower em 25/08/2011

    2 páginasCH01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 05/05/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/05/2011

    Estado do capital em 16/05/2011

    • Capital: GBP 104,180
    SH01

    Estado do capital em 01/04/2011

    • Capital: GBP 1
    8 páginasSH19

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    legacy

    2 páginasSH20

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2010

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/05/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Anna Maughan em 02/11/2009

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Jonathan Bower em 02/11/2009

    2 páginasCH01

    Contas preparadas até 31/03/2009

    4 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    5 páginas363a

    Contas preparadas até 31/03/2008

    4 páginasAA

    Contas preparadas até 31/03/2007

    4 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    Contas preparadas até 31/03/2006

    4 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Quem são os diretores de EPOK LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MAUGHAN, Anna
    Homeserve Plc
    Cable Drive
    WS2 7BN Walsall
    Homeserve Plc
    England
    Secretário
    Homeserve Plc
    Cable Drive
    WS2 7BN Walsall
    Homeserve Plc
    England
    British53071850001
    BOWER, David Jonathan
    Homeserve Plc
    Cable Drive
    WS2 7BN Walsall
    Homeserve Plc
    England
    Diretor
    Homeserve Plc
    Cable Drive
    WS2 7BN Walsall
    Homeserve Plc
    England
    EnglandBritishChartered Accountant132462170002
    ECKERSLEY, Paul Francis
    Annandale
    Watling Street
    ME2 3UQ Higham
    Kent
    Secretário
    Annandale
    Watling Street
    ME2 3UQ Higham
    Kent
    BritishAccountant76257460001
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Secretário
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    ROBINSON, Miles Goring Dudley
    Meeching
    Witherenden Hill, Burwash
    TN19 7JP Etchingham
    East Sussex
    Secretário
    Meeching
    Witherenden Hill, Burwash
    TN19 7JP Etchingham
    East Sussex
    BritishChartered Accountant66336650001
    WATKINS, Margaret Mary
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    Secretário nomeado
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    British900006760001
    ECKERSLEY, Paul Francis
    Annandale
    Watling Street
    ME2 3UQ Higham
    Kent
    Diretor
    Annandale
    Watling Street
    ME2 3UQ Higham
    Kent
    BritishAccountant76257460001
    HARLEY, Robert Ian
    Little Brook End Farm
    Holdings Lane Kempsey
    WR5 3LF Worcester
    Diretor
    Little Brook End Farm
    Holdings Lane Kempsey
    WR5 3LF Worcester
    BritishDirector42785040001
    KING, Christopher David
    The House Northdown Service Station
    Charing
    TN27 0JS Ashford
    Kent
    Diretor
    The House Northdown Service Station
    Charing
    TN27 0JS Ashford
    Kent
    BritishOperations Manager50839020002
    MCCOLLUM, Angela Jean
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    Diretor nomeado
    52 New Town
    TN22 5DE Uckfield
    East Sussex
    British900006750001
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Diretor
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    ROBERTSON, Philip John Anthony
    The Warren
    Potter Row
    HP16 9LT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Warren
    Potter Row
    HP16 9LT Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director20626440003
    ROBINSON, Miles Goring Dudley
    Meeching
    Witherenden Hill, Burwash
    TN19 7JP Etchingham
    East Sussex
    Diretor
    Meeching
    Witherenden Hill, Burwash
    TN19 7JP Etchingham
    East Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant66336650001
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Diretor
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    United KingdomBritishSolicitor154322040001
    WAITE, Anthony Richard
    Pendle House Smugglers Lane
    TN6 1TG Crowborough
    East Sussex
    Diretor
    Pendle House Smugglers Lane
    TN6 1TG Crowborough
    East Sussex
    BritishSales And Marketing Executive39125060003
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Diretor
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    BritishFinancial Accountant36622750002

    EPOK LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed charge
    Criado em 14/07/1998
    Entregue em 16/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and the debt financing agreement of even date (as defined therein)
    Breve descrição
    Fixed equitable charge any debt purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement together with associated rights (as defined) which fails to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason.
    Pessoas com direito
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transações
    • 16/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 25/06/1998
    Entregue em 04/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Property k/a hydro house unit 9 new road industrial estate new road ditton kent ME20 6AF. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 04/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chatel mortgage
    Criado em 06/08/1997
    Entregue em 08/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Breve descrição
    All the company's right title and interest in and to 4 x pearpoint flexiprope (explosion proof) with generator sony pro.video toshiba laptop & printer plus full set of tools rods bung hydraulic manhole lifter winch and exotox minigas id no's;-701/705/706/707, 3 x telespec mainline rig with additional fixtures under id no's 702/703/704 and 2 x remote control 2 wheel neolith towed jetter with full set of tools and bungs exotox minigsas id no's;-611/612. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 08/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 29/07/1997
    Entregue em 04/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a hydro house new road ditton ayleford kent t/no's;-K132369 and K561139. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 06/05/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 30/06/1994
    Entregue em 01/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a land and buildings to south west of kiln barn road ditton and f/h land 2 kiln barn road tog: with all buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 01/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 06/05/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 30/06/1994
    Entregue em 01/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 01/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 06/05/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/06/1994
    Entregue em 29/06/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific charge over its goodwill benefit of any licences patents patent applications inventions trade marks trade names registered designs copyrights know-how and any other intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/06/1994Registro de uma garantia (395)
    • 06/05/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0