KINGSTON PARK LEISURE LIMITED

KINGSTON PARK LEISURE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaKINGSTON PARK LEISURE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02933546
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    • (9999) /

    Onde fica KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    40-44 Coombe Road
    KT3 4QF New Malden
    Surrey
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    KEWBELL PLC27/05/199427/05/1994

    Quais são as últimas contas de KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2009

    Quais são as últimas submissões para KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado do capital em 17/12/2010

    • Capital: GBP 0.50
    5 páginasSH19

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Memorando e estatutos

    16 páginasMA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 27/05/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Endereço do domicílio registado alterado de Cannons House 40-44 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QF em 08/06/2010

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    10 páginas288a

    Contas preparadas até 31/12/2007

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas403a

    Quem são os diretores de KINGSTON PARK LEISURE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HOLBEN, David George
    49 Sandilands Road
    Fulham
    SW6 2BD London
    Secretário
    49 Sandilands Road
    Fulham
    SW6 2BD London
    British104903050001
    DOYLE, Kevan-Peter
    34 Park Road
    TW1 2PX Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    34 Park Road
    TW1 2PX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish78237230007
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Diretor
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    GARRETT, David Trevarthen
    Heath Lodge
    Heath Drive
    KT20 7QQ Walton On The Hill
    Surrey
    Secretário
    Heath Lodge
    Heath Drive
    KT20 7QQ Walton On The Hill
    Surrey
    British36379600001
    HARRINGTON, Michael
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    Secretário nomeado
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    British900008620001
    OLIVER, Martin Timothy
    Flat 2 Chivelston
    78 Parkside Wimbledon
    SW19 5LH London
    Secretário
    Flat 2 Chivelston
    78 Parkside Wimbledon
    SW19 5LH London
    British50764370001
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Secretário
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    British63240980001
    PRIEST, Jane
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    Secretário
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    British47391270002
    SHILCOF, Sarah Alexis
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    Secretário
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    British40539040001
    STREETS, Matthew Alexander
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Secretário
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    British40530270001
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Secretário
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    British50807620002
    ANDREW, James Richard Elliott
    Henderson Road
    SW18 3RR London
    15
    Diretor
    Henderson Road
    SW18 3RR London
    15
    United KingdomBritish139764120001
    APPLEYARD, Barrie Kenneth
    Brentwood
    Kemp Road
    HU14 3LZ Swanland
    North Humberside
    Diretor
    Brentwood
    Kemp Road
    HU14 3LZ Swanland
    North Humberside
    British41875210001
    FISH, Mark Andrew
    The Orchard
    Court Road
    SL6 8LQ Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    The Orchard
    Court Road
    SL6 8LQ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish44086510002
    GOTLA, Christopher James
    60 Elm Grove Road
    Barnes
    SW13 0BT London
    Diretor
    60 Elm Grove Road
    Barnes
    SW13 0BT London
    British29863490001
    HARRIS, Martin
    Levels House
    BA5 1PF Bleadney
    Somerset
    Diretor
    Levels House
    BA5 1PF Bleadney
    Somerset
    British75882330001
    JESSOP, Christopher
    Shawfield Street
    SW3 4BD London
    8
    Diretor
    Shawfield Street
    SW3 4BD London
    8
    United KingdomBritish139864830001
    KETTELL, Stephanie Margaret
    2 Walton House
    GL20 8EX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Diretor
    2 Walton House
    GL20 8EX Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish63120930001
    LOVATT, Helen Edith
    Saxham Villa
    108 Evesham Road
    GL52 2AN Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Saxham Villa
    108 Evesham Road
    GL52 2AN Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish46017690001
    MISRA, Arnu Kumar
    Hedgerow House 9 Rockwood Road
    Calverley
    LS28 5AB Leeds
    Yorkshire
    Diretor
    Hedgerow House 9 Rockwood Road
    Calverley
    LS28 5AB Leeds
    Yorkshire
    United KingdomBritish227695390001
    MORGAN, Stephen John
    47 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    47 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish23190140003
    OLIVER, Martin Timothy
    25 Cranes Drive
    KT5 8AJ Surbiton
    Surrey
    Diretor
    25 Cranes Drive
    KT5 8AJ Surbiton
    Surrey
    British50764370002
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Diretor
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    EnglandBritish63240980001
    PRIEST, Jane
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    Diretor
    39 Redwood Road
    Kinver
    DY7 6JP Stourbridge
    West Midlands
    British47391270002
    PSYLLIDES, Milton Nicholas
    Westfield 1 Halloughton Road
    Four Oaks
    B74 2QG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    Westfield 1 Halloughton Road
    Four Oaks
    B74 2QG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33137230002
    SHILCOF, Sarah Alexis
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    Diretor
    Roebuck House
    20 The Horsepool
    LE10 2DH Burbage
    Leicestershire
    British40539040001
    STREETS, Matthew Alexander
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Diretor
    6 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    United KingdomBritish40530270001
    TEGELAARS, Harm Bartholomew
    Farnham House
    Farnham Lane
    TN3 0JT Langton Green
    Kent
    Diretor
    Farnham House
    Farnham Lane
    TN3 0JT Langton Green
    Kent
    UkDutch16805470001
    WILLIAMS, Christopher
    22 Hardman Road
    KT2 6RH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Diretor
    22 Hardman Road
    KT2 6RH Kingston Upon Thames
    Surrey
    British102280630001
    WISEMAN, David Charles
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    Diretor
    53 Dorset Drive
    HA8 7NT Edgware
    Middlesex
    EnglandBritish50807620002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001

    KINGSTON PARK LEISURE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security accession deed to a debenture dated 10 may 2001 between inter alia,health club investments limited (the "parent"),health club investments limited and health club acquisitions limited (the "charging companies") and the royal bank of scotland PLC (the "security agent") (the "debenture")
    Criado em 03/07/2001
    Entregue em 13/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) to any secured party (as defined) or any other obligor (as defined) in any manner under or in respect of the finance documents (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 13/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 04/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 25/03/1996
    Entregue em 15/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    To secure the performance of the covenants of the company to the chargee contained in a lease of even date
    Breve descrição
    Land situate close to the junction of st james street with humber bank kingston park in the city of kingston upon hull.
    Pessoas com direito
    • Kingston upon Hull City Council
    Transações
    • 15/04/1996Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 25/03/1996
    Entregue em 10/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the loan agreement dated 24TH march 1995
    Breve descrição
    Property close to the junction of st james street with humber bank, kingston park, kingston upon hull. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/04/1996Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 16/06/1995
    Entregue em 28/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 28/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge of agreement for lease
    Criado em 12/04/1995
    Entregue em 25/04/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 24TH march 1995
    Breve descrição
    (1) by way of assignment the agreement dated 12TH april 1995 (2) by way of assignment all the interest of the company in the land close to the junction of st james street with humber bank, kingston park, kingston upon hull under the lease to be granted by kingston upon hull city council to the ccompany and (3) by way of fixed charge the plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils owned by the company at the property.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 25/04/1995Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 12/04/1995
    Entregue em 24/04/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 24/04/1995Registro de uma garantia (395)
    • 04/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0