MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED

MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02936861
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    • captação, tratamento e fornecimento de água (36000) / Captação, tratamento e distribuição de água; gestão de resíduos; atividades de descontaminação e recuperação

    Onde fica MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    6 Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    Kent
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MAPLIN ENVIRONMENTAL LIMITED08/06/199408/06/1994

    Quais são as últimas contas de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/08/2015

    Quais são as últimas submissões para MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01
    A5JHMX2O

    Declaração anual preparada até 22/06/2016 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/06/2016

    Estado do capital em 24/06/2016

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X59RT0H4

    Endereço do domicílio registado alterado de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP para 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR em 15/06/2016

    1 páginasAD01
    X596UDXT

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/08/2015

    3 páginasAA
    X57DJO00

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/03/2015 para 31/08/2015

    1 páginasAA01
    X4EN8JMP

    Declaração anual preparada até 08/06/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital26/06/2015

    Estado do capital em 26/06/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X4AB22BF

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY England para 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP

    1 páginasAD02
    X4AB21ZT

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP

    1 páginasAD04
    X4AB2201

    Nomeação de Mr Hugh Francis Edmonds como secretário em 14/05/2015

    2 páginasAP03
    X47HFP5K

    Término da nomeação de John William Charles Charlton como secretário em 30/04/2015

    1 páginasTM02
    X47HE0ZE

    Término da nomeação de John William Charles Charlton como diretor em 30/04/2015

    1 páginasTM01
    X47HE0R7

    Endereço do domicílio registado alterado de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY para 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP em 01/04/2015

    1 páginasAD01
    X44DG6JL

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2014

    7 páginasAA
    A3N3PCW1

    Declaração anual preparada até 08/06/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/06/2014

    Estado do capital em 15/06/2014

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X3A33Y8W

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2013

    7 páginasAA
    A2OF2IBD

    Satisfação total da garantia 9

    4 páginasMR04
    A2J2PT7E

    Declaração anual preparada até 08/06/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    X2BH6CYY

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2012

    8 páginasAA
    A239GGG2

    Término da nomeação de John Prowse como diretor

    1 páginasTM01
    X1ZZ7P9L

    Declaração anual preparada até 08/06/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    X1B0SM4Y

    Detalhes do secretário alterados para John William Charles Charlton em 07/06/2012

    2 páginasCH03
    X1B0SM3V

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 7-11 Nelson Street Southend on Sea Essex SS1 1EH

    1 páginasAD02
    X1B0SM4I

    Detalhes do diretor alterados para Mr Richard Hodgson em 07/06/2012

    2 páginasCH01
    X1B0SM4B

    Quem são os diretores de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    EDMONDS, Hugh Francis
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Secretário
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    197706140001
    HODGSON, Richard George
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    Diretor
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    EnglandBritishFinance Director155847280001
    BETTS, Andrew Graham
    89 Essex Way
    SS7 1LR Southend
    Essex
    Secretário
    89 Essex Way
    SS7 1LR Southend
    Essex
    British74184230002
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Secretário
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    BritishSales Director94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Secretário
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    British151170420001
    DEDMAN, David Francis
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    Secretário
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    BritishAccountant43888390002
    HOLLAND, James Lindsay
    14 Kingsley Lane
    SS7 3TU Thundersley
    Essex
    Secretário
    14 Kingsley Lane
    SS7 3TU Thundersley
    Essex
    British71288860001
    NICHOLLS, Craig Lewis
    18 Bishopsteighton
    Shoeburyness
    SS3 8AF Southend On Sea
    Secretário
    18 Bishopsteighton
    Shoeburyness
    SS3 8AF Southend On Sea
    British41940890001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretário nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Diretor
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishSales Director94118060001
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Diretor
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishDirector94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Diretor
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector - Shared Services119598150002
    DEDMAN, David Francis
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    Diretor
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant43888390002
    FAULDS, Alistair
    Flat 2 Wilow Court
    Rosewood Lane
    SS3 9EW Shoeburyness
    Essex
    Diretor
    Flat 2 Wilow Court
    Rosewood Lane
    SS3 9EW Shoeburyness
    Essex
    BritishWater Services Contractor39299610002
    HOLLAND, James Lindsay
    Claremont
    Private Road
    CM2 8TH Chelmsford
    Essex
    Diretor
    Claremont
    Private Road
    CM2 8TH Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director71288860002
    HOLLAND, Mabel Grace
    22 Rowan Way
    Canewdon
    SS4 3PD Rochford
    Essex
    Diretor
    22 Rowan Way
    Canewdon
    SS4 3PD Rochford
    Essex
    BritishCompany Secretary41940950001
    LEE, Michael William
    Fern Cottage
    Dark Lane, Bliss Gate
    DY14 9YN Rock Nr. Bewdley
    Worcestershire
    Diretor
    Fern Cottage
    Dark Lane, Bliss Gate
    DY14 9YN Rock Nr. Bewdley
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector66729790001
    NICHOLLS, Craig Lewis
    18 Wambrook
    Shoeburyness
    SS3 8BW Southend On Sea
    Essex
    Diretor
    18 Wambrook
    Shoeburyness
    SS3 8BW Southend On Sea
    Essex
    BritishContract Manager41940890002
    PROWSE, John
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    Diretor
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    EnglandBritishChief Executive Officer96786510001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 30/04/2010
    Entregue em 12/05/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 12/05/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 15/10/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 21/08/2000
    Entregue em 31/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 31/08/2000Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Criado em 04/08/2000
    Entregue em 05/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Breve descrição
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transações
    • 05/08/2000Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 10/08/1998
    Entregue em 27/08/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and pursuant to or in connection with a financing agreement (as therein defined) and on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Invoice Finance Limited
    Transações
    • 27/08/1998Registro de uma garantia (395)
    • 24/03/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 18/03/1998
    Entregue em 25/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a 19 sirdar road raylthe goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 25/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 24/03/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 06/03/1998
    Entregue em 11/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 11/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 24/03/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security interest agreement
    Criado em 02/03/1998
    Entregue em 10/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All sums now and in the future credited to account number/designation Q999-1 held by the company with the royal bank of scotland international limited or any account which derives in whole or in part from such account.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Criado em 26/08/1997
    Entregue em 05/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debts or debts which were then or thereafter owing to the company on the account or accounts number 7125695 and all interest (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 05/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 22/07/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture deed
    Criado em 29/04/1997
    Entregue em 03/05/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 03/05/1997Registro de uma garantia (395)
    • 22/07/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0