PARKMAN HOLDINGS LIMITED

PARKMAN HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPARKMAN HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02946586
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PARKMAN HOLDINGS LIMITED?

    • Outras atividades de engenharia (71129) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica PARKMAN HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    2nd Floor
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PARKMAN HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PARKMAN LIMITED07/09/199407/09/1994
    AGENTMID LIMITED07/07/199407/07/1994

    Quais são as últimas contas de PARKMAN HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2022

    Quais são as últimas submissões para PARKMAN HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2022

    14 páginasAA

    legacy

    231 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Término da nomeação de Clive Thomas como diretor em 17/11/2022

    1 páginasTM01

    Nomeação de Steven Philip Van Raalte como diretor em 16/11/2022

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 12/09/2022 com atualizações

    4 páginasCS01

    Estado do capital em 23/05/2022

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Término da nomeação de Helen Julia Samuels como diretor em 18/03/2022

    1 páginasTM01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/06/2021

    19 páginasAA

    Nomeação de Jaime Foong Yi Tham como secretário em 24/09/2021

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Philip Higgins como secretário em 24/09/2021

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 06/09/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Basil Christopher Mendonca como diretor em 12/08/2021

    2 páginasAP01

    Alteração dos detalhes de Kier Parkman Gb Limited como pessoa com controlo significativo em 05/07/2021

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de 81 Fountain Street Manchester M2 2EE England para 2nd Floor Optimum House, Clippers Quay Salford M50 3XP em 05/07/2021

    1 páginasAD01

    Nomeação de Helen Julia Samuels como diretor em 22/02/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Mark Whittaker como diretor em 23/02/2021

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2020

    19 páginasAA

    Quem são os diretores de PARKMAN HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    THAM, Jaime Foong Yi
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    Secretário
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    288140850001
    MENDONCA, Basil Christopher
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    Diretor
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    EnglandBritish280160760001
    VAN RAALTE, Steven Philip
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    Diretor
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    EnglandBritish302570330001
    COBDEN, Nicky
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    169438110001
    ENGMANN, Catherine
    11 Tudor Way
    SL4 5LT Windsor
    Berkshire
    Secretário
    11 Tudor Way
    SL4 5LT Windsor
    Berkshire
    British92722710004
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Secretário
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    HIGGINS, Philip
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    Secretário
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    262535030001
    LEE, Kelly
    Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    British138708240001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Secretário
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    MELGES, Bethan
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    209553140001
    PREECE, Richard Alec
    3 Moorings Close
    Parkgate
    CH64 6TL South Wirral
    Secretário
    3 Moorings Close
    Parkgate
    CH64 6TL South Wirral
    British7353920001
    SHAW, Christine Ann
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    161033760001
    SJOGREN, Carl
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    153648630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOND, Eric
    Henfold 120 Henfold Road
    Astley
    M29 7EX Manchester
    Lancashire
    Diretor
    Henfold 120 Henfold Road
    Astley
    M29 7EX Manchester
    Lancashire
    British11646690001
    BOYLE, Stephen
    108 Merlin Park
    Portishead
    BS20 8RW Bristol
    Diretor
    108 Merlin Park
    Portishead
    BS20 8RW Bristol
    British40722890001
    CLEVERLY, Graham
    Claremont
    68 Tarvin Road
    CH3 7DF Chester
    Cheshire
    Diretor
    Claremont
    68 Tarvin Road
    CH3 7DF Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish86693320001
    DAVIES, Philip John
    29 Ann Boleyn House
    Queens Reach
    KT8 9DE East Molesey
    Surrey
    Diretor
    29 Ann Boleyn House
    Queens Reach
    KT8 9DE East Molesey
    Surrey
    British24640030005
    DIBB-FULLER, Edwin
    Old Bartons
    Hardwick Road, Whitchurch On Thames
    RG8 7HW Reading
    Berkshire
    Diretor
    Old Bartons
    Hardwick Road, Whitchurch On Thames
    RG8 7HW Reading
    Berkshire
    British67994500001
    ELLIS, Christopher John
    5 Alderdale Drive
    High Lane
    SK6 8BX Stockport
    Cheshire
    Diretor
    5 Alderdale Drive
    High Lane
    SK6 8BX Stockport
    Cheshire
    British12943580001
    ENGLAND, Paul David
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish153205540001
    HANDLEY, John
    Brook Cottage
    Brinsea Batch, Congresbury
    BS49 5JP Bristol
    Diretor
    Brook Cottage
    Brinsea Batch, Congresbury
    BS49 5JP Bristol
    British97439420001
    HARRIS, Rodney Hewer
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Export House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish104017460001
    HAYES, Brian
    1 Woodbank Hall Cottage
    Shotwick Lane
    CH1 6HY Woodbank
    Chester
    Diretor
    1 Woodbank Hall Cottage
    Shotwick Lane
    CH1 6HY Woodbank
    Chester
    British36639460001
    HOWARD, Lee
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish208700940001
    HOWITT, Ian Howard
    The Spinney Mill Lane
    Rainhill
    L35 6NG Prescot
    Merseyside
    Diretor
    The Spinney Mill Lane
    Rainhill
    L35 6NG Prescot
    Merseyside
    EnglandBritish43712120001
    JACKSON, Geoffrey Stephen
    4 Mount Close
    CR8 5DP Kenley
    Surrey
    Diretor
    4 Mount Close
    CR8 5DP Kenley
    Surrey
    British36881700001
    JONES, John Roger
    27 Suncliffe Drive
    CV8 1FH Kenilworth
    Warwickshire
    Diretor
    27 Suncliffe Drive
    CV8 1FH Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish34017980001
    KILNER, Robert Graham
    11 The Limes
    Culcheth
    WA3 4HE Warrington
    Cheshire
    Diretor
    11 The Limes
    Culcheth
    WA3 4HE Warrington
    Cheshire
    British11487410002
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Diretor
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish36957420004
    MAWSON, David
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish156809630007
    NOTT, Nigel Alfred
    19 Shoscombe
    BA2 8LS Bath
    Diretor
    19 Shoscombe
    BA2 8LS Bath
    EnglandBritish11646680001
    OGDEN, David William
    16 Elm Drive
    Greasby
    CH49 3NP Wirral
    Merseyside
    Diretor
    16 Elm Drive
    Greasby
    CH49 3NP Wirral
    Merseyside
    British30192420001
    PARKMAN, Hugh Charles
    38 East Saint Helen Street
    OX14 5EB Abingdon
    Oxfordshire
    Diretor
    38 East Saint Helen Street
    OX14 5EB Abingdon
    Oxfordshire
    British11486420002
    PEARCE, Roger William
    Postacre Shiphill
    Tatsfield
    TN16 2JY Westerham
    Kent
    Diretor
    Postacre Shiphill
    Tatsfield
    TN16 2JY Westerham
    Kent
    United KingdomBritish2785060001

    Quem são as pessoas com controle significativo de PARKMAN HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    06/04/2016
    Optimum House, Clippers Quay
    M50 3XP Salford
    2nd Floor
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroUnited Kingdom
    Número de registro02359925
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    PARKMAN HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage debenture made between parkman group limited,parkman limited,parkman group professional services limited and parkman property management limited (collectively the "charging subsidiaries") and the royal bank of scotland PLC
    Criado em 12/07/2000
    Entregue em 21/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 21/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge debenture
    Criado em 12/07/2000
    Entregue em 17/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and/or the debenture to the holders of the loan notes issued pursuant to the loan note instrument (as defined therein)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Gresham Trust P.L.C as Trustee for Itself and Holders of the Loan Notes from Time to Time
    Transações
    • 17/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 12/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 24/05/2000
    Entregue em 02/06/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a letter dated 24TH may 2000
    Breve descrição
    Please refer to form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 02/06/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 10/02/1997
    Entregue em 13/02/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A fixed charge over all the "deposit(s)" together with all interest from time to time accruing thereon, it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon, details of charged deposit contract(s)-barclays bank PLC re parkman limited irish punt deposit account 42876477.. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/02/1997Registro de uma garantia (395)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 17/10/1995
    Entregue em 24/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 11/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 08/12/1994
    Entregue em 16/12/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/12/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0