HAMPSON SHIMS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | HAMPSON SHIMS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 02948479 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de HAMPSON SHIMS LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica HAMPSON SHIMS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 7 Harbour Building Waterfront West DY5 1LN Dudley Road Brierley Hill West Midlands |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de HAMPSON SHIMS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
VECTOR PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED | 18/12/1996 | 18/12/1996 |
PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED | 30/08/1994 | 30/08/1994 |
STOPJUMP SERVICES LIMITED | 14/07/1994 | 14/07/1994 |
Quais são as últimas contas de HAMPSON SHIMS LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2011 |
Quais são as últimas submissões para HAMPSON SHIMS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 14/07/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Ram Swamy em 08/02/2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 14/07/2011 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Ram Swamy como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Howard Kimberley como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 38 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
legacy | páginas | MG01 | ||||||||||
legacy | 14 páginas | MG01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2010 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Kim Ward como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Malcolm George Dolan como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 14/07/2010 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2009 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Kim Stephen Ward em 11/12/2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Howard Kimberley em 05/10/2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Kim Stephen Ward em 05/10/2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2008 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2007 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a |
Quem são os diretores de HAMPSON SHIMS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLAN, Malcolm George | Secretário | 30 Ferndown Close Bloxwich WS3 3XH Walsall West Midlands | British | Chartered Secretary | 73207060001 | |||||
DOLAN, Malcolm George | Diretor | Dudley Road Waterfron West DY5 1LN Brierley Hill 7 Harbour Buildings West Midlands | United Kingdom | British | Company Secretary | 73207060001 | ||||
SWAMY, Ram | Diretor | 7 Harbour Building Waterfront West DY5 1LN Dudley Road Brierley Hill West Midlands | England | British | Finance Director | 156224980002 | ||||
KIMBERLEY, Howard Fraser | Secretário | 8 Lyttelton Road WR9 7AA Droitwich Spa Worcestershire | British | Finance Director | 75325410002 | |||||
SMITH, Stephen Anthony | Secretário | 12 Chestnut Avenue HA6 1HR Northwood Middlesex | British | Company Director | 6780200001 | |||||
WELCH, John Reginald | Secretário | 22 Balmoral Road Kingshurst B36 0JT Birmingham West Midlands | British | 2243210001 | ||||||
BLAW DUCTS LIMITED | Secretário | Caradon House 24 Queens Road KT13 9UX Weybridge Surrey | 50754710001 | |||||||
CARADON SERVICES LIMITED | Secretário | Caradon House 24 Queens Road KT13 9UX Weybridge Surrey | 5096460003 | |||||||
RALLIP HOLDINGS LIMITED | Secretário | Novar House 24 Queens Road KT13 9UX Weybridge Surrey | 35130970001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
DAVIES, Christopher Erith | Diretor | Hollytree The Common Wellington Heath HR8 1LY Ledbury Herefordshire | British | Chief Executive | 48167130002 | |||||
FISCHER, Andrew Olaf | Diretor | The Chestnuts Chestnut Close, Peakirk PE6 7NW Peterborough Cambridgeshire | England | German | Company Director | 70312740001 | ||||
FISHER, Ian | Diretor | 145 King Henrys Road NW3 3RD London | United Kingdom | Israeli | Company Director | 51776160003 | ||||
FLETCHER, Alan Thomas | Diretor | 26 Loudoun Road NW8 0LT London | British | Company Director | 14669590001 | |||||
GASH, Michael Alfred | Diretor | 54 Richmond Hill Road Edgbaston B15 3AZ Birmingham | British | Finance Director | 6255580001 | |||||
KIMBERLEY, Howard Fraser | Diretor | Waterfront West Dudley Road DY5 1LN Brierley Hill 7 Harbour Building West Midlands | England | British | Finance Director | 75325410002 | ||||
SMITH, Stephen Anthony | Diretor | 12 Chestnut Avenue HA6 1HR Northwood Middlesex | British | Director | 6780200001 | |||||
WARD, Kim Stephen | Diretor | 7 Harbour Building Waterfront West DY5 1LN Dudley Road Brierley Hill West Midlands | England | British | Chief Executive | 71325320006 | ||||
CARADON NOMINEES LIMITED | Diretor | Caradon House 24 Queens Road KT13 9UX Weybridge Surrey | 43553300002 | |||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
RALLIP HOLDINGS LIMITED | Diretor | Novar House 24 Queens Road KT13 9UX Weybridge Surrey | 35130970001 |
HAMPSON SHIMS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Criado em 24/11/2010 Entregue em 02/12/2010 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee and debenture | Criado em 10/12/1996 Entregue em 13/12/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (as therein defined) or any of them under the financing documents (as therein defined) | |
Breve descrição All right, title and interest present and future in and to:- the right to receive payment under the acquisition documents and the keyman policies (both as defined on form 395 and within the deed). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0