ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED

ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02967532
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    JOHN DOYLE MAINTENANCE LIMITED04/11/199404/11/1994
    DETAILSTOCK LIMITED14/09/199414/09/1994

    Quais são as últimas contas de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2020

    Quais são as últimas submissões para ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew Latham Nelson em 25/11/2021

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020

    16 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019

    16 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Paul Birch em 16/01/2020

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Andrew Lee Milner como diretor em 12/12/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018

    12 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Sherard Secretariat Services Limited em 02/09/2019

    1 páginasCH04

    Alteração dos detalhes de Accord Limited como pessoa com controlo significativo em 02/09/2019

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ para Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB em 02/09/2019

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    11 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2017 com atualizações

    3 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Accord Limited como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    2 páginasPSC05

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    11 páginasAA

    Nomeação de Mr Paul Birch como diretor em 12/05/2017

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    10 páginasAA

    Quem são os diretores de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Secretário
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    Diretor
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    United KingdomBritish76116640004
    NELSON, Andrew Latham
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Diretor
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritish36191090004
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secretário
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    HARVEY, Stephen George
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    Secretário
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    British67162750001
    KELLY, Paula Frona
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    Secretário
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    British95469920001
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Secretário
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    British67736270003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABBEY, Geoffrey Michael
    The Habit
    The Street
    SG11 2QR Braughing
    Hertfordshire
    Diretor
    The Habit
    The Street
    SG11 2QR Braughing
    Hertfordshire
    British65112520001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    ATHERTON, David
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish109058740001
    CHASTON, Stuart Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish126271790001
    CHEETHAM, James Richard
    Ashfield
    Weston Rhyn
    SY10 7SD Oswestry
    Salop
    Diretor
    Ashfield
    Weston Rhyn
    SY10 7SD Oswestry
    Salop
    British45753210001
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Diretor
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    FARRAR, Roland Martin
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish29009510002
    FELLOWES PRYNNE, Philip Windover
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Diretor
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British80861440001
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    JOYCE, Martin John
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish72254420003
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Diretor
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish51438040006
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Diretor
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    MILLER, Paul Sydney
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    Diretor
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    British39022040001
    MILNER, Andrew Lee
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Diretor
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish133714170002
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Diretor
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish67736270003
    SHUTKEVER, Adam Emmanuel
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    Diretor
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    United KingdomBritish81455510002
    STEFANOU, Stefanos
    13 Park Mews
    AL9 5EP Hatfield
    Hertfordshire
    Diretor
    13 Park Mews
    AL9 5EP Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish44867700001
    STEFANOU, Stelio Haralambos
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    Diretor
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2749630007
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    06/04/2016
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3693911
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 12/11/2007
    Entregue em 28/11/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee, Richard Butcher as Pension Trustee, Pitman Trusteeslimited as Pension Trustee, Philip Bridge as Pension Trustee and Each of Their Assignors Transferees and Successiors from Time to Time
    Transações
    • 28/11/2007Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 20/12/2006
    Entregue em 22/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each chargor to the finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the security created under the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 22/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A guarantee and debenture
    Criado em 25/06/1999
    Entregue em 05/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All the present and/or future obligations and liabilities due or to become due from the company to national westminster bank PLC as agent and trustee for the secured parties (the "security trustee") and any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)(including the debenture)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 05/07/1999Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 11/11/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 10/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 31/03/1995
    Entregue em 04/04/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/04/1995Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 11/11/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 10/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0