MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED

MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02968618
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED?

    • Atividades de consultoria em tecnologia da informação (62020) / Informação e comunicação

    Onde fica MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Old Change House
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    STRATEGIC ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED12/09/199412/09/1994

    Quais são as últimas contas de MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Satisfação total da garantia 029686180004

    4 páginasMR04

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 03/03/2017

    • Capital: GBP 10
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    24 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/08/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Nomeação de Mr Jonathan Mark Heather como secretário em 19/08/2016

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Anjum O'neill como diretor em 19/08/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Anjum O'neill como secretário em 19/08/2016

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Simon David Stanhope Baines como diretor em 19/08/2016

    2 páginasAP01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Sentinel House Harvest Crescent Ancells Business Park Fleet Hampshire GU51 2UZ

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para Sentinel House Harvest Crescent Ancells Business Park Fleet Hampshire GU51 2UZ

    1 páginasAD02

    Declaração anual preparada até 28/08/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/09/2015

    Estado do capital em 04/09/2015

    • Capital: GBP 5,100,000
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    17 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/08/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital29/08/2014

    Estado do capital em 29/08/2014

    • Capital: GBP 5,100,000
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    18 páginasAA

    Memorando e estatutos

    11 páginasMEM/ARTS

    Resoluções

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Loan agreement 25/10/2013
    RES13
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Registo da garantia 029686180004

    107 páginasMR01

    Declaração anual preparada até 28/08/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/09/2013

    Estado do capital em 02/09/2013

    • Capital: GBP 5,100,000
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Philip Basil Wood em 07/08/2013

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HEATHER, Jonathan Mark
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    Secretário
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    213324520001
    BAINES, Simon David Stanhope
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    Diretor
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    EnglandBritishCompany Director183158120001
    WOOD, Philip Basil
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    Diretor
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    United KingdomBritishDirector72282230010
    COLE, Nigel John
    15 Mount Grace Road
    EN6 1QY Potters Bar
    London
    Secretário
    15 Mount Grace Road
    EN6 1QY Potters Bar
    London
    BritishDirector83890790001
    FARRELLY, Ian Brian
    Park Avenue
    GU15 2NG Camberley
    20
    Surrey
    Secretário
    Park Avenue
    GU15 2NG Camberley
    20
    Surrey
    BritishSolicitor71425280002
    HARRIMAN, Michael Noel
    50a Warrington Crescent
    W9 1EP London
    Secretário
    50a Warrington Crescent
    W9 1EP London
    British36611850001
    LIDDLE, Gerald Ernest
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    Secretário
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    BritishDirector8458270002
    LIDDLE, Gerald Ernest
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    Secretário
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    BritishCompany Secretary8458270002
    MANNING, Susan
    86 Cricklade Avenue
    Streatham Hill
    SW2 3HQ London
    Secretário
    86 Cricklade Avenue
    Streatham Hill
    SW2 3HQ London
    British51069130001
    MOTE, David Edward
    60 Dry Hill Road
    TN10 3BX Tonbridge
    Kent
    Secretário
    60 Dry Hill Road
    TN10 3BX Tonbridge
    Kent
    BritishManagement Consultant40527410001
    O'NEILL, Anjum
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    Secretário
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    BritishSolicitor129229830003
    SALLITT, Henry William Baines
    Appletree Cottage
    Newtown Common
    RG20 9DA Newbury
    Berkshire
    Secretário
    Appletree Cottage
    Newtown Common
    RG20 9DA Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director105009660001
    SPIVEY, Hilary
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    Secretário
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    BritishDirector1846560001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Secretário nomeado
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    CALDER, Stuart James
    Hillbrick Barn
    Lenborough
    MK18 4BP Buckingham
    Diretor
    Hillbrick Barn
    Lenborough
    MK18 4BP Buckingham
    BritishDirector84470180001
    CAMPBELL, Stuart Clark
    Magnolia Cottage Heath Lane
    Ewshot
    GU10 5AW Crondall
    Surrey
    Diretor
    Magnolia Cottage Heath Lane
    Ewshot
    GU10 5AW Crondall
    Surrey
    EnglandBritishManagement Consultant141321810001
    COLE, Nigel John
    15 Mount Grace Road
    EN6 1QY Potters Bar
    London
    Diretor
    15 Mount Grace Road
    EN6 1QY Potters Bar
    London
    UkBritishDirector83890790001
    FOX, Colin Sidney Russell
    46 Hampstead Way
    NW11 7XX London
    Diretor
    46 Hampstead Way
    NW11 7XX London
    United KingdomBritishDirector45197410001
    HARRIMAN, Michael Noel
    50a Warrington Crescent
    W9 1EP London
    Diretor
    50a Warrington Crescent
    W9 1EP London
    BritishManager36611850001
    HART, Michael John
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    Diretor
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    BritishCompany Director118672700001
    HERRICK, Fraser James
    9 Sylvester Road
    N2 8HN London
    Diretor
    9 Sylvester Road
    N2 8HN London
    BritishDirector79342250001
    LIDDLE, Gerald Ernest
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    Diretor
    69a Badshot Park
    Badshot Lea
    GU9 9NE Farnham
    Surrey
    Great BritainBritishCompany Secretary8458270002
    MANNING, Susan
    86 Cricklade Avenue
    Streatham Hill
    SW2 3HQ London
    Diretor
    86 Cricklade Avenue
    Streatham Hill
    SW2 3HQ London
    BritishAccountant51069130001
    MARSH, John Bernard
    Hedsor Road
    SL8 5DP Bourne End
    The Mill House
    Buckinghamshire
    Diretor
    Hedsor Road
    SL8 5DP Bourne End
    The Mill House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishConsultant9847190003
    MOTE, David Edward
    60 Dry Hill Road
    TN10 3BX Tonbridge
    Kent
    Diretor
    60 Dry Hill Road
    TN10 3BX Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishManagement Consultant40527410001
    O'NEILL, Anjum
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    Diretor
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    EnglandBritishSolicitor129229830004
    PHILLIPS, Michael Scott
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector59751680001
    SALLITT, Henry William Baines
    Appletree Cottage
    Newtown Common
    RG20 9DA Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Appletree Cottage
    Newtown Common
    RG20 9DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director105009660001
    SPIVEY, Hilary
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    Diretor
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector1846560001
    THOMPSON, Ian John, Dr
    13 Llanaway Road
    GU7 3EB Godalming
    Surrey
    Diretor
    13 Llanaway Road
    GU7 3EB Godalming
    Surrey
    United KingdomBritishConsultant57273000001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Diretor nomeado
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    Quem são as pessoas com controle significativo de MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Microgen Financial Systems
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    06/04/2016
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Número de registro03188002
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    MICROGEN ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 28/10/2013
    Entregue em 31/10/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 31/10/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 26/07/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Assignment of intellectual property rights
    Criado em 25/09/2000
    Entregue em 03/10/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Assigns to the chargee all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding the third party rights but subject to and with the benefit of the exploitation agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transações
    • 03/10/2000Registro de uma garantia (395)
    • 13/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/06/2000
    Entregue em 05/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the loan agreement (for an initial principal amount of £2,975,000) dated 23 june 2000
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transações
    • 05/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 13/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 17/06/1998
    Entregue em 26/06/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 26/06/1998Registro de uma garantia (395)
    • 25/05/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0