BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED

BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaBALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02990953
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Suite 9 The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    South Humberside
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CHARGENOTICE LIMITED16/11/199416/11/1994

    Quais são as últimas contas de BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Carlton Greener como diretor em 11/03/2013

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Denise Brenda Robinson como diretor em 08/03/2013

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Trevor Martin Sands como diretor em 08/03/2013

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Denise Brenda Robinson como secretário em 08/03/2013

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    3 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de Origin 4 Origin Way Europarc Grimsby South Humberside DN37 9TZ United Kingdom em 04/09/2012

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Trevor Martin Sands como diretor em 30/04/2012

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 20/03/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/03/2012

    Estado do capital em 23/03/2012

    • Capital: GBP 386,734.5
    SH01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/10/2011 para 31/12/2011

    1 páginasAA01

    Nomeação de Mrs Denise Brenda Robinson como diretor em 30/09/2011

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil Richard Carrick como diretor em 30/09/2011

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2010

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/03/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Enter into facilities agreement 29/11/2010
    RES13

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 01/11/2009

    4 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de Fish Dock Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3NW em 12/05/2010

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 20/03/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Carlton Greener em 31/03/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Neil Richard Carrick em 31/03/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Mrs Denise Brenda Robinson em 31/03/2010

    1 páginasCH03

    Contas preparadas até 26/10/2008

    4 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Facilities agreement 31/07/2009
    RES13

    legacy

    1 páginas288a

    Quem são os diretores de BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FOXFORD, Michael John
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    Secretário
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    British96216260001
    GREENER, Carlton
    3
    Roewood Lane
    SK10 2PQ Macclesfield
    Cheshire
    Secretário
    3
    Roewood Lane
    SK10 2PQ Macclesfield
    Cheshire
    British290436370002
    ROBINSON, Denise Brenda
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Secretário
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    British112343690001
    ROBSON, Alan James
    14 Mill Place
    DN35 8ND Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    Secretário
    14 Mill Place
    DN35 8ND Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    British74547040004
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Secretário nomeado
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BROWNE, Peter
    11 Ravenhill Park Gardens
    BT6 0DH Belfast
    Diretor
    11 Ravenhill Park Gardens
    BT6 0DH Belfast
    British42230710001
    CARRICK, Neil Richard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Diretor
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritish166312330001
    GREENER, Carlton
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Diretor
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritish290436370002
    JONSSON, Per Anders
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    Diretor
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    EnglandSwedish189569310001
    MEADOWCROFT, Norman Russell
    3 Barley Drive
    Bramhall
    SK7 2QB Stockport
    Cheshire
    Diretor
    3 Barley Drive
    Bramhall
    SK7 2QB Stockport
    Cheshire
    British28601500001
    MEDDINGS, David William
    13 Montagu Square
    W1H 1RB London
    Diretor
    13 Montagu Square
    W1H 1RB London
    British4416070001
    ROBINSON, Denise Brenda
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Diretor
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritish112343690001
    RUSSELL, Richard
    12 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    Diretor
    12 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    United KingdomBritish41506100001
    SANDS, Trevor Martin
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Diretor
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomUnited Kingdom164235220001
    SMALLBONE, Timothy Charles
    22 Crossway
    Didsbury
    M20 6TT Manchester
    Lancashire
    Diretor
    22 Crossway
    Didsbury
    M20 6TT Manchester
    Lancashire
    British42089430001
    STEVENSON, James Neil
    Rathlin
    Hallpath
    DG13 0EG Langholm
    Dumfriesshire
    Diretor
    Rathlin
    Hallpath
    DG13 0EG Langholm
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish759350001
    THOMAS, Adrian Peter Harrison
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish26500450003
    TURNHEIM, Stuart
    33 Breeze Mount
    Prestwich
    M25 0AH Manchester
    Lancashire
    Diretor
    33 Breeze Mount
    Prestwich
    M25 0AH Manchester
    Lancashire
    British41506080001
    WOOD, Frederick William
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    Diretor
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish3783250004
    WOOLLEY, Anthony
    22 Cross Street
    DE22 3FZ Derby
    Derbyshire
    Diretor
    22 Cross Street
    DE22 3FZ Derby
    Derbyshire
    British42230670001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Diretor nomeado
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Composite debenture
    Criado em 26/03/2009
    Entregue em 09/04/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Frederick William Wood, Ronald Briggs Heaton, Paul Arthur Bradbury, Alan Smith and Vincent Rodger Whyte Mccracken as the Trustees of the Cosalt Retirement Plan
    Transações
    • 09/04/2009Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 26/03/2009
    Entregue em 04/04/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the "Security Trustee")
    Transações
    • 04/04/2009Registro de uma garantia (395)
    Mortgage which was presented for registration in northern ireland on 17TH september 1997
    Criado em 12/09/1997
    Entregue em 25/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that piece or parcel of ground situate on the south side of the road leading from ballyclare to ballynure k/a the ballynure road situate lying and being in le ballyclare in the parish of ballynure and county of antrim. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 25/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 28/09/1999Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 06/10/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 02/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 04/09/1997
    Entregue em 17/09/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 17/09/1997Registro de uma garantia (395)
    • 06/10/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 02/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of permanent health policy
    Criado em 25/10/1995
    Entregue em 26/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 26/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of protection plan policy
    Criado em 25/10/1995
    Entregue em 26/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment) with sun alliance and london assurance company liited and all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 26/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 27/01/1995
    Entregue em 10/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transações
    • 10/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of life policy
    Criado em 27/01/1995
    Entregue em 01/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 01/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 27/01/1995
    Entregue em 30/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 30/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 27/01/1995
    Entregue em 30/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that piece or parcel of ground situate at 44 ballyclare road ballyclare le ballyclare in the parish of ballyclare and county of antrim and the present or future goodwiull of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 30/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0