PANORMOS 3 LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPANORMOS 3 LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03015083
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PANORMOS 3 LTD?

    • Outras atividades de serviços n.e.c. (96090) / Outras atividades de serviços

    Onde fica PANORMOS 3 LTD?

    Endereço do escritório registrado
    30 City Road
    London
    EC1Y 2AB
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PANORMOS 3 LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ROGENSI IP LIMITED02/07/200702/07/2007
    SI CORPORATE DEVELOPMENT LIMITED22/05/200222/05/2002
    SPEAKERS INTERNATIONAL CORPORATE DEVELOPMENT LTD17/06/199617/06/1996
    SPEAKERS INTERNATIONAL CORPORATE TRAINING LIMITED19/09/199519/09/1995

    Quais são as últimas contas de PANORMOS 3 LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2012

    Qual é o status da última declaração anual para PANORMOS 3 LTD?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para PANORMOS 3 LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 19/01/2013 com lista completa de acionistas

    9 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/05/2013

    Estado do capital em 24/05/2013

    • Capital: GBP 141.72
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Martin Ronald Coburn em 07/01/2013

    2 páginasCH01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/06/2012

    6 páginasAA

    legacy

    2 páginasMG02

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed rogensi ip LIMITED\certificate issued on 21/06/12
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name21/06/2012

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15
    change-of-name21/06/2012

    Alteração do nome" por resolução

    NM01

    Contas de isenção total preparadas até 30/06/2011

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 19/01/2012 com lista completa de acionistas

    9 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Brian Terrence Reynolds em 01/01/2012

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Rosemary Thomason em 01/01/2012

    1 páginasCH03

    Contas de isenção total preparadas até 30/06/2010

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 19/01/2011 com lista completa de acionistas

    20 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 19/01/2010 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Contas preparadas até 30/06/2009

    14 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Andrew William Frederick Wolfe em 27/01/2010

    1 páginasCH03

    Detalhes do secretário alterados para Rosemary Thomason em 19/01/2010

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Alexander Dugald Gregory Macphail em 27/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Mr Martin Coburn em 19/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Alexander Dugald Gregory Macphail em 19/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Martin Coburn em 27/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Rosemary Thompson em 27/01/2010

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Simon Lindsey Edwin Holland em 19/01/2010

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de PANORMOS 3 LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    THOMASON, Rosemary
    30 City Road
    London
    EC1Y 2AB
    Secretário
    30 City Road
    London
    EC1Y 2AB
    British146071940002
    WOLFE, Andrew William Frederick
    High Street
    Markyate
    AL3 8JG St Albans
    Gate Cottage 109
    Hertfordshire
    Secretário
    High Street
    Markyate
    AL3 8JG St Albans
    Gate Cottage 109
    Hertfordshire
    British132136510001
    COBURN, Martin Ronald
    Percy Road
    TW2 6JE Twickenham
    157
    England
    Diretor
    Percy Road
    TW2 6JE Twickenham
    157
    England
    EnglandBritish138543860003
    HILES, Colin Alan, Mr.
    305 Faversham Road
    Seasalter
    CT5 4BN Whitstable
    Kent
    Diretor
    305 Faversham Road
    Seasalter
    CT5 4BN Whitstable
    Kent
    United KingdomBritish113837950001
    HOLLAND, Simon Lindsey Edwin
    The Templars, Temple Guiting
    GL54 5RP Cheltenham
    Ailsa Hame
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Diretor
    The Templars, Temple Guiting
    GL54 5RP Cheltenham
    Ailsa Hame
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141934660001
    MACPHAIL, Alexander Dugald Gregory
    Nicosia Road
    SW18 3RN London
    7
    United Kingdom
    Diretor
    Nicosia Road
    SW18 3RN London
    7
    United Kingdom
    EnglandBritish132136600003
    REYNOLDS, Brian Terrence
    30 City Road
    London
    EC1Y 2AB
    Diretor
    30 City Road
    London
    EC1Y 2AB
    United KingdomAustralian140689990001
    WOLFE, Andrew William Frederick
    Gate Cottage
    109 High Street Markyate
    AL3 8JG St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Gate Cottage
    109 High Street Markyate
    AL3 8JG St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish99807540001
    BELLINGHAM, Rosemary
    30 Cicada Road
    SW18 2NW London
    Secretário
    30 Cicada Road
    SW18 2NW London
    British39158210001
    HUGHES HALLETT, David
    5 Little Bookham Street
    Little Bookham
    KT23 3AA Leatherhead
    Surrey
    Secretário
    5 Little Bookham Street
    Little Bookham
    KT23 3AA Leatherhead
    Surrey
    British72191950003
    MACPHAIL, Alexander Dugald Gregory
    204 London House
    19 Old Court Place
    W8 4PL London
    Secretário
    204 London House
    19 Old Court Place
    W8 4PL London
    British43701210001
    THOMASON, Rosemary Margaret
    9 Yattendon Court
    RG18 0UT Yattendon
    Berkshire
    Secretário
    9 Yattendon Court
    RG18 0UT Yattendon
    Berkshire
    British105880180001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretário nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    DRYSDALE, Timothy David
    Lodge Farm House
    Copyhold Lane
    RH17 5ED Cuckfield
    West Sussex
    Diretor
    Lodge Farm House
    Copyhold Lane
    RH17 5ED Cuckfield
    West Sussex
    British87168090001
    HUGHES HALLETT, Andrew William
    66 Reading Road
    RG9 1AU Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    66 Reading Road
    RG9 1AU Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish76749970002
    HUGHES HALLETT, Andrew William
    Flat 8
    29 Station Road
    SW13 London
    Diretor
    Flat 8
    29 Station Road
    SW13 London
    British76749970001
    HUGHES HALLETT, David
    5 Little Bookham Street
    Little Bookham
    KT23 3AA Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    5 Little Bookham Street
    Little Bookham
    KT23 3AA Leatherhead
    Surrey
    British72191950003
    JONES, Miah Gwynfor, Dr
    Garth Hall
    LL49 9TN Porthmadog
    Gwynedd
    Diretor
    Garth Hall
    LL49 9TN Porthmadog
    Gwynedd
    WalesBritish66161140002
    MACPHAIL, Alexander Dugald Gregory
    12 Burntwood Lane
    SW17 0JZ London
    Diretor
    12 Burntwood Lane
    SW17 0JZ London
    EnglandBritish73439560001
    SCOTT, Harry Richard Spencer
    19 Wethered Park
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    19 Wethered Park
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British93584500001
    STEELE, James
    The White House 2 Priory Way
    Datchet
    SL3 9JQ Slough
    Berkshire
    Diretor
    The White House 2 Priory Way
    Datchet
    SL3 9JQ Slough
    Berkshire
    British76750080001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    PANORMOS 3 LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 23/06/2006
    Entregue em 27/06/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Cash in a separate designated interest earning account comprising an initial deposit of £16,904.14.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition Ag
    Transações
    • 27/06/2006Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 18/02/2005
    Entregue em 24/02/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Cash in a separate designated interest earning account comprising an initial deposit of £16,384.20, together with any deposits which may be added to such account and all money from time to time withdrawn from it.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition A.G.
    Transações
    • 24/02/2005Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 18/02/2005
    Entregue em 24/02/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Cash in a separate designation interest earning account comprising an initial deposit of £18,506.25 together with any deposits which may be added to such account and all money from time to time withdrawn from it.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition A.G.
    Transações
    • 24/02/2005Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 07/01/2005
    Entregue em 12/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 12/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 26/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Criado em 15/12/2004
    Entregue em 17/12/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Cash in a separate designated interest earning account comprising an initial deposit of £7,147.53.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition A.G.
    Transações
    • 17/12/2004Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 24/08/2001
    Entregue em 29/08/2001
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein relating to the premises known as unit 9 berghem mews blythe road london W14 between the company (as tenant) and the chargee (as landlord)
    Breve descrição
    All the company's right title benefit and interest in and to all cash in a separate designated interest earning account in which the initial deposit of of £14,969.50 is placed.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition A.G.
    Transações
    • 29/08/2001Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 12/03/2001
    Entregue em 14/03/2001
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 3RD october 1996 made between (1)ronald michael harris and malcolm webber and (2) catalyst (europe) limited or the rent deposit deedx
    Breve descrição
    Cash in a separate designated interest earning account comprising an initial deposit pf £8,636.25 such account opened by and held in the name of the landlord of the lease together with any deposits which may be added to such account and all money from time to time withdrawn from it.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition a G
    Transações
    • 14/03/2001Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 06/06/2000
    Entregue em 09/06/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Breve descrição
    The deposit of £18,506.25 held in the name of mayfair edition A.G. together with any deposits.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition A.G.
    Transações
    • 09/06/2000Registro de uma garantia (395)
    • 14/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 16/12/1999
    Entregue em 23/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease and the rent deposit deed of even date
    Breve descrição
    £7,147.53.
    Pessoas com direito
    • Mayfair Edition A.G.
    Transações
    • 23/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 14/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 19/04/1999
    Entregue em 28/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 14/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 19/08/1998
    Entregue em 29/08/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £7,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Rent deposit of £7,200.00.
    Pessoas com direito
    • Maclaurin Group Limited
    Transações
    • 29/08/1998Registro de uma garantia (395)
    • 14/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 19/08/1998
    Entregue em 28/08/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Breve descrição
    Deposit of £7,200.
    Pessoas com direito
    • Maclaurin Group Limited
    Transações
    • 28/08/1998Registro de uma garantia (395)
    • 14/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0