NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED

NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNSB RETAIL SYSTEMS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03015908
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    First Floor Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NSB RETAIL SYSTEMS PLC30/01/199530/01/1995

    Quais são as últimas contas de NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2022

    Quais são as últimas submissões para NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 30/01/2024 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/09/2022

    18 páginasAA

    legacy

    69 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    69 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaração de confirmação apresentada em 30/01/2023 com atualizações

    7 páginasCS01

    Estado do capital em 12/01/2023

    • Capital: GBP 0.999944
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 12/01/2023
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 14/12/2022

    • Capital: GBP 0.999944
    4 páginasSH01

    Memorando e estatutos

    7 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/09/2021

    18 páginasAA

    legacy

    68 páginasPARENT_ACC

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Approval of accounts 26/09/2022
    RES13

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaração de confirmação apresentada em 30/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 030159080012

    1 páginasMR04

    Quem são os diretores de NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    VISTRA COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Secretário
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro00555893
    97584300011
    BAUM, David
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    Diretor
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    CanadaCanadianIn-House Lawyer197997360001
    BOLT, Geoffrey Robert
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    Secretário
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    British16454990001
    CHEUNG, Yu-Ho
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    Secretário
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    BritishSolicitor129862370001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretário nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ABRAHAM, Ashley Richard
    39 Platts Lane
    NW3 7NN London
    Diretor
    39 Platts Lane
    NW3 7NN London
    EnglandBritishBanker54808030001
    ALLEN, Paul Christopher
    Broom House
    Bayleys Hill Road
    TN8 7AS Bough Beech
    Kent
    Diretor
    Broom House
    Bayleys Hill Road
    TN8 7AS Bough Beech
    Kent
    United KingdomIrishDirector185112730001
    BECKETT, Nikaila Susan
    The Old Manor
    DT2 8TQ Dorchester
    Dorset
    Diretor
    The Old Manor
    DT2 8TQ Dorchester
    Dorset
    United KingdomBritishManager125142900001
    BENTLER, Mark J., Mr.
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    Diretor
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    CanadaCanadianAccountant197997370001
    BOLT, Geoffrey Robert
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    Diretor
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    EnglandBritishAccountant16454990001
    BRIMS, John Charles Roy
    Four Seasons
    Hillfoot, Bucklebury
    RG7 6PG Reading
    Berkshire
    Diretor
    Four Seasons
    Hillfoot, Bucklebury
    RG7 6PG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant72118430001
    CARRELL, Michael Eddie
    Shooters
    Westmill
    SG9 9LJ Buntingford
    Hertfordshire
    Diretor
    Shooters
    Westmill
    SG9 9LJ Buntingford
    Hertfordshire
    BritishSoftware Engineer16003460001
    CHATWIN, Martin Anthony
    Clifton House 2 Newfield Place
    Dore
    S17 3ER Sheffield
    Diretor
    Clifton House 2 Newfield Place
    Dore
    S17 3ER Sheffield
    EnglandBritishConsultant141351250001
    CHEUNG, Yu-Ho, Mr.
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    Diretor
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    EnglandBritishSolicitor129862370004
    CLARK, Richard John
    c/o Epicor Software (Uk) Limited
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No.1
    Berkshire
    England
    Diretor
    c/o Epicor Software (Uk) Limited
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No.1
    Berkshire
    England
    EnglandBritishAccountant91263440002
    FERGUSON, David Sinclair
    2469, Rivers Road N.W.
    Atlanta
    FOREIGN 30305 Georgia
    Usa
    Diretor
    2469, Rivers Road N.W.
    Atlanta
    FOREIGN 30305 Georgia
    Usa
    AmericanRetail Consultant120316060001
    FRAZER, Virginia May
    Branksomewood Road
    GU51 4JY Fleet
    Branksome House
    Hampshire
    Diretor
    Branksomewood Road
    GU51 4JY Fleet
    Branksome House
    Hampshire
    BritishVp-Human Resources International129779470001
    HATFIELD, Alan John
    The Rowans
    Buckworth
    PE28 5AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    Diretor
    The Rowans
    Buckworth
    PE28 5AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishSales Director111419140001
    HENNING, David
    210 Gentlewoods Dc
    Cary
    Nc 27518
    Usa
    Diretor
    210 Gentlewoods Dc
    Cary
    Nc 27518
    Usa
    UsaCeo121435430002
    IRELAND, John David
    Patterson Road
    Austin
    1380
    Texas
    Usa
    Diretor
    Patterson Road
    Austin
    1380
    Texas
    Usa
    United StatesAmericanDirector And General Counsel129773050002
    JOHNSON, Peter Robert
    3524 Jackson Street
    San Francisco
    FOREIGN California
    94118
    Usa
    Diretor
    3524 Jackson Street
    San Francisco
    FOREIGN California
    94118
    Usa
    AustralianManager54805470002
    LABORDE, Jeffrey Monroe
    Suite 2500
    Atlanta
    945 East Paces Ferry Rd Ne
    Georgia 30326
    United States
    Diretor
    Suite 2500
    Atlanta
    945 East Paces Ferry Rd Ne
    Georgia 30326
    United States
    GeorgiaAmericanNone Supplied232934100001
    LASSNER, William Michael Victor
    328 Kensington Avenue
    Westmount
    Quebec H3z 2h3
    Canada
    Diretor
    328 Kensington Avenue
    Westmount
    Quebec H3z 2h3
    Canada
    CanadianExecutive74567210001
    LINDSAY, Iain Dixon
    Parkway
    SL7 1YL Marlow
    Marlow International
    United Kingdom
    Diretor
    Parkway
    SL7 1YL Marlow
    Marlow International
    United Kingdom
    United KingdomBritishLawyer109197530002
    MCALEESE, John
    5 Cavendish Gardens
    Winnersh
    RG41 5TG Wokingham
    Berkshire
    Diretor
    5 Cavendish Gardens
    Winnersh
    RG41 5TG Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishRetail Consultant125362020001
    MITCHELL, Stuart Roger
    60 William Hunt Mansions
    Somerville Avenue
    SW13 8HT London
    Diretor
    60 William Hunt Mansions
    Somerville Avenue
    SW13 8HT London
    New ZealandDirector1447530003
    MONRO, Angus
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    Diretor
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritishDirector79054360001
    MOORER, Seale
    2905 Indigo Bush Way
    Naples
    FOREIGN Florida
    34105
    Usa
    Diretor
    2905 Indigo Bush Way
    Naples
    FOREIGN Florida
    34105
    Usa
    AmericanDirector65641530003
    QUARTERMAINE, Mark Richard
    Gary Cottage
    London Road
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    Diretor
    Gary Cottage
    London Road
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishCoo206030570001
    ROSE, Stuart Alan Ransom
    4 St Johns House
    30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Diretor
    4 St Johns House
    30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    BritishCo Director73189720001
    STOTLAND, Howard
    561 Lansdowne Avenue
    West Mount
    FOREIGN Quebec H32 2ls
    Canada
    Diretor
    561 Lansdowne Avenue
    West Mount
    FOREIGN Quebec H32 2ls
    Canada
    CanadianExecutive24566610001
    VICKERY, Alan Graham
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director4180850001
    ZACK, Stanley Ernest
    5822 Einstein
    FOREIGN Montreal
    Qye H4w 2y6
    Canada
    Diretor
    5822 Einstein
    FOREIGN Montreal
    Qye H4w 2y6
    Canada
    CanadianManager75045070001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Quem são as pessoas com controle significativo de NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    06/04/2016
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro10238826
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 11/02/2021
    Entregue em 11/02/2021
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    None.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Wilmington Savings Fund Society, Fsb
    Transações
    • 11/02/2021Registro de uma garantia (MR01)
    • 09/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 17/04/2020
    Entregue em 22/04/2020
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Keybank National Association
    Transações
    • 22/04/2020Registro de uma garantia (MR01)
    • 09/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 23/07/2018
    Entregue em 31/07/2018
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch, as Collateral Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transações
    • 31/07/2018Registro de uma garantia (MR01)
    • 24/03/2020Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 02/10/2017
    Entregue em 04/10/2017
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    None.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Macquarie Capital Funding Llc
    Transações
    • 04/10/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 31/07/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 01/09/2016
    Entregue em 12/09/2016
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Ubs Ag, Stamford Branch (The Collateral Agent)
    Transações
    • 12/09/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 31/07/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Pledge agreement
    Criado em 13/11/2003
    Entregue em 28/11/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the nsb parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All stock & other equity interests. All the right, title & interest in & to such stock & equity interests.
    Pessoas com direito
    • 3068358 Canada Inc.
    Transações
    • 28/11/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/11/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 13/11/2003
    Entregue em 28/11/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the nsb parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3068358 Canada Inc
    Transações
    • 28/11/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/11/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/11/2002
    Entregue em 04/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 04/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of charge
    Criado em 03/03/2000
    Entregue em 17/03/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under all or any of the finance documents (as defined in a facility letter dated 27TH january 2000)
    Breve descrição
    All sums of money deposited by the company deposited to the credit of account number 90863432 with barclays bank. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 17/03/2000Registro de uma garantia (395)
    • 07/06/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 03/04/1996
    Entregue em 24/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £10,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The rental deposit of £10,000 and the amount from time to time standing to the credit of a deposit account at barclays bank PLC.
    Pessoas com direito
    • Palace Street Investments PLC
    Transações
    • 24/04/1996Registro de uma garantia (395)
    • 07/06/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/02/1995
    Entregue em 17/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    $300,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Peter R.Johnson
    Transações
    • 17/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0