GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED

GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03020221
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    • Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias

    Onde fica GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o R P RENDLE & CO LIMITED
    9 Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    West Midlands
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LANDMARK CARE FACILITIES LIMITED21/02/200221/02/2002
    COMMUNITY DEVELOPMENTS LIMITED30/04/199830/04/1998
    STOPPA LIMITED17/11/199517/11/1995
    MARKETEL LIMITED09/02/199509/02/1995

    Quais são as últimas contas de GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Qual é o status da última declaração anual para GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 11/12/2013

    14 páginas4.68

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    15 páginas4.71

    Certificado de pagamento integral aos credores

    2 páginas4.51

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Endereço do domicílio registado alterado de * 4Th Floor 3-5 Swallow Place London W1B 2AF* em 06/12/2012

    1 páginasAD01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Anton David Curtis em 11/10/2012

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Mr Anton David Curtis em 11/10/2012

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Mr Jeremy Ungelson em 08/10/2012

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 09/02/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/03/2012

    Estado do capital em 08/03/2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2010

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 09/02/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2009

    10 páginasAA

    Declaração anual preparada até 09/02/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Endereço do domicílio registado alterado de * 12-14 St Christopher's Place London W1U 1NB* em 25/02/2010

    2 páginasAD01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/09/2009 para 31/12/2009

    3 páginasAA01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/09/2008

    9 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    3 páginas395

    legacy

    3 páginas395

    legacy

    3 páginas288a

    Quem são os diretores de GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Secretário
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    BritishDirector115446010001
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector151245590002
    UNGELSON, Jeremy
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector125304300002
    CLARKE, Rachel Ann
    5 Longridge Avenue
    NE7 7LB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretário
    5 Longridge Avenue
    NE7 7LB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British81840100001
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Secretário
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    EnglishFinance Director40354440003
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Secretário
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    BritishAccountant Director143242660001
    MCCAFFERTY, Mark John
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    Secretário
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    British81370550001
    MCLEISH, William David
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    Secretário
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    British168970640001
    MICHELSON, Allan Denis
    33 North Avenue
    Gosforth
    NE3 4DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretário
    33 North Avenue
    Gosforth
    NE3 4DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British13305820001
    MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Secretário
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    British73852970001
    RILEY, Michelle
    2 Camberwell Close
    NE11 9TZ Gateshead
    Tyne & Wear
    Secretário
    2 Camberwell Close
    NE11 9TZ Gateshead
    Tyne & Wear
    BritishCompany Secretary52057290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Diretor
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    EnglandEnglishFinance Director40354440003
    LEWIS, Gary Owen
    Mount Farm
    Eighton Banks
    NE9 7YP Gateshead
    Diretor
    Mount Farm
    Eighton Banks
    NE9 7YP Gateshead
    BritishDirector51006650004
    LEWIS, Gary Owen
    Valemount Eighton Banks
    NE9 7YL Gateshead
    Tyne & Wear
    Diretor
    Valemount Eighton Banks
    NE9 7YL Gateshead
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director51006650001
    LEWIS, Gary Owen
    4 Larwood Court
    DH3 3QQ Chester Le Street
    County Durham
    Diretor
    4 Larwood Court
    DH3 3QQ Chester Le Street
    County Durham
    BritishDirector41951370002
    LEWIS, Joanne Lynn
    17 Bewicke View
    DH3 1RU Birtley
    Diretor
    17 Bewicke View
    DH3 1RU Birtley
    BritishAdministration Manager41951380004
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Diretor
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    United KingdomBritishAccountant Director143242660001
    MCCAFFERTY, Mark John
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    Diretor
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    BritishChartered Accountant81370550001
    MCGRATH, Kay
    23 Hazelmoor
    NE31 1DH Hebburn
    Tyne & Wear
    Diretor
    23 Hazelmoor
    NE31 1DH Hebburn
    Tyne & Wear
    BritishCare Executive103145700001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Diretor
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    BritishDirector26177180002
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Diretor
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishDirector174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Diretor
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishDirector77274540003
    STROWBRIDGE, John Michael Barrie
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishBusinessman Director157860840001

    GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of legal charge
    Criado em 14/11/2007
    Entregue em 23/11/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    F/H land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transações
    • 23/11/2007Registro de uma garantia (395)
    Deed of assignment
    Criado em 14/11/2007
    Entregue em 23/11/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases in respect of f/h land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transações
    • 23/11/2007Registro de uma garantia (395)
    An amendment and restatement deed to a debenture dated 10 march 2006 and
    Criado em 30/06/2006
    Entregue em 17/07/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC, in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of They Trustee)
    • The Royal Bank of Scotland PLC, in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Thefinance Parties and Secured Parties (The Securit
    Transações
    • 17/07/2006Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of accession
    Criado em 02/05/2006
    Entregue em 04/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee or the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Mill lodge care centre 1A moorside place bradford west yorkshire t/n WYK677390 and WYK730706, crabwall hall residential home parkgate road millington chester t/n's CH246622 CH305068 and CH334555, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Graphite Capital Management LLP
    Transações
    • 04/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 11/04/2006
    Entregue em 21/04/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    F/H & l/h mill lodge care centre, 1A moorside place, bradford, west yorkshire t/nos. WYK677390 and WYK730706. F/h & l/hcrabwell hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos. CH2466. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Mr John Strowbridge (The "Trustee")
    Transações
    • 21/04/2006Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Accession deed
    Criado em 11/04/2006
    Entregue em 26/04/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver or any other person or persons on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The f/h property k/a grangewood care centre, chester road, shiney row, tyne and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland as Security for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    • The Royal Bank of Scotland as Security for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transações
    • 26/04/2006Registro de uma garantia (395)
    • 19/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 10/08/2004
    Entregue em 17/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 17/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 20/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 08/04/2003
    Entregue em 19/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a former grangewood service station chester road shiney row sunderland tyne and wear t/no: TY94518.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 19/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 20/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 23/06/1998
    Entregue em 24/06/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land situate near radford avenue and baxter avenue kidderminster t/n-WR30985.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 24/06/1998Registro de uma garantia (395)
    • 15/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 23/06/1998
    Entregue em 24/06/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H all that parcel of land situate at pershore road selly park birmingham west midlands t/nos: WM211875 and WM519519.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 24/06/1998Registro de uma garantia (395)
    • 24/03/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    14/05/2014Data de dissolução
    12/12/2012Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Richard Paul Rendle
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    Profissional
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0