THE BRICK BUSINESS LIMITED

THE BRICK BUSINESS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHE BRICK BUSINESS LIMITED
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03029861
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DENTON SANDOWN LIMITED01/03/199501/03/1995

    Quais são as últimas contas de THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2017
    Próximas contas vencem em30/09/2018
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Qual é o status da última declaração de confirmação para THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até17/12/2017
    Próxima declaração de confirmação vence31/12/2017
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até17/12/2016
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2025

    8 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2024

    8 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2023

    8 páginasLIQ03

    Término da nomeação de Paul Stevenson como diretor em 02/03/2023

    1 páginasTM01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2022

    7 páginasLIQ03

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:Secretary of state release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2021

    8 páginasLIQ03

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    13 páginasLIQ10

    Nomeação de um liquidador voluntário

    15 páginas600

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2020

    7 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2019

    7 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2018

    7 páginasLIQ03

    Declaração de solvência

    6 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 26/10/2017

    LRESSP

    Nomeação de Mr Keith Stuart Barker como diretor em 01/09/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Harald Anton Schwarzmayr como diretor em 01/09/2017

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    13 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 17/12/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 17/12/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/01/2016

    Estado do capital em 12/01/2016

    • Capital: GBP 900,002
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Harald Anton Schwarzmayr em 01/02/2011

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 17/12/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/01/2015

    Estado do capital em 14/01/2015

    • Capital: GBP 900,002
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Harald Anton Schwarzmayr em 01/10/2009

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GRACE, Michael
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Secretário
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    188990920001
    BARKER, Keith Stuart
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Diretor
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish110773520001
    ALLY, Bibi Rahima
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    Secretário
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    British38963210001
    FEW, Kaye Suzanne
    14 Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    Cheshire
    Secretário
    14 Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    Cheshire
    British119910110001
    RICHARDS, Wayne
    Spring Cottage
    Park Lane Boarshurst
    OL3 7DZ Greenfield
    Saddleworth
    Secretário
    Spring Cottage
    Park Lane Boarshurst
    OL3 7DZ Greenfield
    Saddleworth
    British27757990002
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Diretor
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    EnglandBritish93024670001
    BODDY, Martyn
    Ladyswood 47 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    Diretor
    Ladyswood 47 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    British108596990001
    BROWN, John Forster
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    Diretor
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    United KingdomBritish4183480002
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Diretor
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    FORBES, Gerard James
    22 Frampton Close
    Middleton
    M24 1PF Manchester
    Diretor
    22 Frampton Close
    Middleton
    M24 1PF Manchester
    British42936480002
    FROST, Neil Ernest
    2 Eccles Close
    Whaley Bridge
    SK12 7RS Stockport
    Cheshire
    Diretor
    2 Eccles Close
    Whaley Bridge
    SK12 7RS Stockport
    Cheshire
    British28520400002
    FURR, Patrick Charles
    Edenbridge Close
    Weston
    CW2 5QU Crewe
    8
    Cheshire
    England
    Diretor
    Edenbridge Close
    Weston
    CW2 5QU Crewe
    8
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish129981870001
    HANNIDES, George Michael
    7 Great North Rd
    Brookmans Park
    AL96AB Hatfield
    Hertfordshire
    Diretor
    7 Great North Rd
    Brookmans Park
    AL96AB Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish127571820001
    JACKSON, John Andrew
    17 Crossfield Road
    Hale
    WA15 8DU Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    17 Crossfield Road
    Hale
    WA15 8DU Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish24857510001
    KIELY, Brian David
    17 Hawthorn Lane
    Ashton-On-Mersey
    M33 5WW Sale
    Cheshire
    Diretor
    17 Hawthorn Lane
    Ashton-On-Mersey
    M33 5WW Sale
    Cheshire
    British99921060001
    KOEKOEK, Bert Jan
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    Diretor
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    NetherlandsDutch119912460001
    LANGMUIR, Hugh Macgillivray
    14 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Diretor
    14 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    British42365820001
    MARGRAVE, Philip John
    9 Marquis Way
    Aldwick
    PO21 4AT Bognor Regis
    West Sussex
    Diretor
    9 Marquis Way
    Aldwick
    PO21 4AT Bognor Regis
    West Sussex
    EnglandBritish51493580001
    REDFERN, Stuart William
    49 Drummond Way
    SK10 4XJ Macclesfield
    Cheshire
    Diretor
    49 Drummond Way
    SK10 4XJ Macclesfield
    Cheshire
    British76159410002
    RICHARDS, Wayne
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    Diretor
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    British27757990001
    RICHARDS, Wayne
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    Diretor
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    British27757990001
    ROBERTS, Gareth Wynford Lewis
    7 Nene Lane
    NN12 6YN Towcester
    Northamptonshire
    Diretor
    7 Nene Lane
    NN12 6YN Towcester
    Northamptonshire
    British81203280001
    SANDFORD, John Martin
    25 Newstead Close
    Poynton
    SK12 1ES Stockport
    Cheshire
    Diretor
    25 Newstead Close
    Poynton
    SK12 1ES Stockport
    Cheshire
    British14927950001
    SCHEUCH, Heimo
    Avenue Des Courses 20
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Diretor
    Avenue Des Courses 20
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    AustriaAustrian100521050001
    SCHWARZMAYR, Harald Anton
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Diretor
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    United KingdomAustrian103815020002
    STEVENSON, Paul
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish113293590001
    VAN RIET, Willy Marie Jean
    Leeuwerikenlaan 14
    Dendermonde
    9200
    Belgium
    Diretor
    Leeuwerikenlaan 14
    Dendermonde
    9200
    Belgium
    Belgian100527520001
    WELHAM, John Harry
    Mayfield Runshaw Lane
    Euxton
    PR7 6HB Chorley
    Lancashire
    Diretor
    Mayfield Runshaw Lane
    Euxton
    PR7 6HB Chorley
    Lancashire
    British27761560002

    Quem são as pessoas com controle significativo de THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaUnlimited Company
    País de registroUk
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3028184
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    THE BRICK BUSINESS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 28/11/2003
    Entregue em 05/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Property being all the mineral beds of brickshale within an area of land containing 67.28 hectares or thereabouts situate at todhills brickworks, todhills, county durham comprised in a lease dated 28 november between (1) the church commissioners for endgland and (2) the company; for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 05/12/2003Registro de uma garantia (395)
    • 02/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/10/2003
    Entregue em 04/11/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All money or liabilities due owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future in any manner whether actual or contingent together with interest
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 04/11/2003Registro de uma garantia (395)
    • 02/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/03/2002
    Entregue em 06/04/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transações
    • 06/04/2002Registro de uma garantia (395)
    • 02/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Amending deed (relating to a composite guarantee and debenture originally dated 20TH march 1995 "the guarantee and debenture")
    Criado em 07/11/1997
    Entregue em 20/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the facility agreement, the finance documents (or any of them), the hedging agreements (or any of them) and the guarantee and debenture
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bankers Trust Companyas Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (As Defined)
    Transações
    • 20/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 09/04/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Amending deed
    Criado em 22/09/1997
    Entregue em 08/10/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement, the finance documents, the hedging agreements and the guarantee & debenture or any of them
    Breve descrição
    All book and other debts all assets property goodwill and undertaking from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bankers Trust Company
    Transações
    • 08/10/1997Registro de uma garantia (395)
    • 09/04/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 20/03/1995
    Entregue em 23/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from brickbuilt limited and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the term loan and revolving credit agreement dated 20TH march 1995 pursuant to which the chargees agreed to make available a term loan of £28,000,000 and a revolving credit facility of up to £4,000,000 to the company (the "facility agreement"), the finance documents, the hedging agreements and this deed in any currency or currencies whether present or future
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bankers Trust Companyas Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (As Defined)
    Transações
    • 23/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 09/04/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 04/03/1995
    Entregue em 06/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or brickbuilt limited to the chargee under the terms of the facility agreement dated 3RD march 1995 or any collateral instrument
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Cinven Limited
    Transações
    • 06/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 21/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    THE BRICK BUSINESS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/10/2017Início da liquidação
    22/09/2017Data da declaração de solvência jurada
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profissional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Emma Cray
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Profissional
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0