GRIPPERRODS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGRIPPERRODS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03041925
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GRIPPERRODS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica GRIPPERRODS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GRIPPERRODS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ARLESHAW LIMITED04/04/199504/04/1995

    Quais são as últimas contas de GRIPPERRODS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Qual é o status da última declaração anual para GRIPPERRODS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para GRIPPERRODS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/08/2015

    8 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/08/2014

    8 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de * Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE United Kingdom* em 30/08/2013

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 01/12/2012 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital17/12/2012

    Estado do capital em 17/12/2012

    • Capital: GBP 9,806,459
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    7 páginasAA

    Declaração dos objetos da sociedade

    21 páginasCC04

    Resoluções

    Resolutions
    23 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 01/12/2011 com lista completa de acionistas

    9 páginasAR01

    Término da nomeação de Michael Hopster como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Elizabeth Honor Lewzey como secretário

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Michael John Hopster como secretário

    1 páginasTM02

    Detalhes do diretor alterados para Elizabeth Honor Lewzey em 04/07/2011

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    7 páginasAA

    Nomeação de Nicolas Paul Wilkinson como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Thomas C. Reeve como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Elizabeth Honor Lewzey como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Paul Flanagan como diretor

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de * East Putney House 84 Upper Richmond Road London SW15 2ST* em 07/07/2011

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Denise Burton como diretor

    2 páginasTM01

    Nomeação de Michael John Hopster como secretário

    2 páginasAP03

    Quem são os diretores de GRIPPERRODS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Secretário
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833030001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Diretor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    REEVE, Thomas C.
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    Diretor
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    United StatesAmerican161822390001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Diretor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish48808690001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Secretário
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157103010001
    LAU, Cheong Koon
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    Secretário
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    Malaysian16337610001
    PAUL, Simon George
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    Secretário
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    British154423590001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretário nomeado
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Diretor
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Diretor
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FARRELL, William Michael
    7 Craigvale Court
    DG1 4QH Dumfries
    Diretor
    7 Craigvale Court
    DG1 4QH Dumfries
    British62063670001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Diretor
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HAZARD, George Anthony
    46 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    Diretor
    46 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    British6369950001
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Diretor
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOUGHTON, Paul David
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    Diretor
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    British95097460001
    JACKSON, Pearse
    3 Woodside
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    Diretor
    3 Woodside
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    Irish61362400001
    LEES, Peter Bryce
    6 Jerviswood
    ML1 4AJ Motherwell
    Lanarkshire
    Diretor
    6 Jerviswood
    ML1 4AJ Motherwell
    Lanarkshire
    British26615220001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MOULDS, Peter John
    2 Millside
    Slitting Mill
    WS15 2FG Rugeley
    Staffordshire
    Diretor
    2 Millside
    Slitting Mill
    WS15 2FG Rugeley
    Staffordshire
    British31029500002
    OWEN, David Evan Penrhyn
    The Old Barn
    Church Lane
    S81 9EH Carlton In Lindrick
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Old Barn
    Church Lane
    S81 9EH Carlton In Lindrick
    Nottinghamshire
    British73849580001
    PAUL, Simon George
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    Diretor
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    EnglandBritish154423590001
    PERSSON, Jan Allan
    3 Wayside
    SW14 7LN London
    Diretor
    3 Wayside
    SW14 7LN London
    Swedish6650000001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Diretor
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    ROBB, Kenneth
    2 Glentruim View
    KA2 0LL Kilmarnock
    Ayrshire
    Diretor
    2 Glentruim View
    KA2 0LL Kilmarnock
    Ayrshire
    British61362350001
    SACK, Adam David
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    Diretor
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    British32459700002
    STANSFIELD, Neil Andrew
    The Laurels, Poets Way
    Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Diretor
    The Laurels, Poets Way
    Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British79347560001
    WIEGMAN, Albert Edward Bernard
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    Diretor
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    British7466220002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Diretor nomeado
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Diretor nomeado
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    GRIPPERRODS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Charge over credit balances
    Criado em 24/04/1998
    Entregue em 07/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The sum of £33,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 29/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 13/01/1998
    Entregue em 21/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this mortgage debenture or in connection with a counter indemnity of even date
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Eac Fund I Gp Limited
    Transações
    • 21/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 29/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over credit balances
    Criado em 10/11/1997
    Entregue em 24/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The sum of £41,300 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 24/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 29/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts
    Criado em 23/10/1997
    Entregue em 30/10/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise
    Breve descrição
    Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge.
    Pessoas com direito
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transações
    • 30/10/1997Registro de uma garantia (395)
    • 27/01/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 05/06/1995
    Entregue em 17/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee under the terms of a credit sale agreement dated 12TH september 1991 and a novation agreement dated 5TH june 1995
    Breve descrição
    The sponge rubber underlay production line situated at the company's premises at walkmill lane, cannock, staffordshire.
    Pessoas com direito
    • Mercat Industrial Limited
    Transações
    • 17/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 12/07/1995Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 21/05/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/06/1995
    Entregue em 15/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Factory warehouse and office premises forming part of the industrial estate at walkmill lane cannock staffordshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 15/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 29/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    GRIPPERRODS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    16/08/2013Início da liquidação
    06/02/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Profissional
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0