GRIPPERRODS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | GRIPPERRODS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03041925 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de GRIPPERRODS LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica GRIPPERRODS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de GRIPPERRODS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| ARLESHAW LIMITED | 04/04/1995 | 04/04/1995 |
Quais são as últimas contas de GRIPPERRODS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2011 |
Qual é o status da última declaração anual para GRIPPERRODS LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para GRIPPERRODS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 8 páginas | 4.71 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/08/2015 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/08/2014 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE United Kingdom* em 30/08/2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de solvência | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 01/12/2012 com lista completa de acionistas | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 21 páginas | CC04 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 23 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 01/12/2011 com lista completa de acionistas | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de Michael Hopster como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Elizabeth Honor Lewzey como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Michael John Hopster como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Elizabeth Honor Lewzey em 04/07/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Nicolas Paul Wilkinson como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Thomas C. Reeve como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Elizabeth Honor Lewzey como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Paul Flanagan como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * East Putney House 84 Upper Richmond Road London SW15 2ST* em 07/07/2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Término da nomeação de Denise Burton como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Michael John Hopster como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Quem são os diretores de GRIPPERRODS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Secretário | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833030001 | |||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Diretor | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||
| REEVE, Thomas C. | Diretor | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Diretor | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretário | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Secretário | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157103010001 | |||||||
| LAU, Cheong Koon | Secretário | 40 Strongbow Road Eltham SE9 1DT London | Malaysian | 16337610001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Secretário | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | British | 154423590001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário nomeado | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BURTON, Denise Patricia | Diretor | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Diretor | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| FARRELL, William Michael | Diretor | 7 Craigvale Court DG1 4QH Dumfries | British | 62063670001 | ||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Diretor | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||
| HAZARD, George Anthony | Diretor | 46 Broad Oaks Road B91 1JB Solihull West Midlands | British | 6369950001 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Diretor | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||
| HOUGHTON, Paul David | Diretor | 2 Mayfield Court Formby L37 7JL Liverpool Merseyside | British | 95097460001 | ||||||
| JACKSON, Pearse | Diretor | 3 Woodside Parkgate DG1 3LY Dumfries | Irish | 61362400001 | ||||||
| LEES, Peter Bryce | Diretor | 6 Jerviswood ML1 4AJ Motherwell Lanarkshire | British | 26615220001 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Diretor | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MOULDS, Peter John | Diretor | 2 Millside Slitting Mill WS15 2FG Rugeley Staffordshire | British | 31029500002 | ||||||
| OWEN, David Evan Penrhyn | Diretor | The Old Barn Church Lane S81 9EH Carlton In Lindrick Nottinghamshire | British | 73849580001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Diretor | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | England | British | 154423590001 | |||||
| PERSSON, Jan Allan | Diretor | 3 Wayside SW14 7LN London | Swedish | 6650000001 | ||||||
| PORTER, Norman Charles | Diretor | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||
| ROBB, Kenneth | Diretor | 2 Glentruim View KA2 0LL Kilmarnock Ayrshire | British | 61362350001 | ||||||
| SACK, Adam David | Diretor | 115 Broadhurst Gardens NW6 3BJ London | British | 32459700002 | ||||||
| STANSFIELD, Neil Andrew | Diretor | The Laurels, Poets Way Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | 79347560001 | ||||||
| WIEGMAN, Albert Edward Bernard | Diretor | 17 Hills Avenue CB1 7UY Cambridge | British | 7466220002 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Diretor nomeado | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
GRIPPERRODS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over credit balances | Criado em 24/04/1998 Entregue em 07/05/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The sum of £33,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 13/01/1998 Entregue em 21/01/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under this mortgage debenture or in connection with a counter indemnity of even date | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge over credit balances | Criado em 10/11/1997 Entregue em 24/11/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The sum of £41,300 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts | Criado em 23/10/1997 Entregue em 30/10/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise | |
Breve descrição Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Chattels mortgage | Criado em 05/06/1995 Entregue em 17/06/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee under the terms of a credit sale agreement dated 12TH september 1991 and a novation agreement dated 5TH june 1995 | |
Breve descrição The sponge rubber underlay production line situated at the company's premises at walkmill lane, cannock, staffordshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 05/06/1995 Entregue em 15/06/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Factory warehouse and office premises forming part of the industrial estate at walkmill lane cannock staffordshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
GRIPPERRODS LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0