UK HIGHWAYS M40 LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | UK HIGHWAYS M40 LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Ativa |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 03045707 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
- Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 8 White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley Kent |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
UK HIGHWAYS A419/417 LIMITED | 24/07/1995 | 24/07/1995 |
TANKAY LIMITED | 12/04/1995 | 12/04/1995 |
Quais são as últimas contas de UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
Vencido | Não |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 31/12/2024 |
Próximas contas vencem em | 30/09/2025 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
Última declaração de confirmação elaborada até | 14/04/2025 |
---|---|
Próxima declaração de confirmação vence | 28/04/2025 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 14/04/2024 |
Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Contas anuais preparadas até 31/12/2023 | 32 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 14/04/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr Brian Love como diretor em 11/05/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr John Stephen Gordon como diretor em 11/05/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Maria Milagros Lopez Simon como diretor em 03/05/2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2022 | 32 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Jamie Pritchard como diretor em 21/04/2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 14/04/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de Ian Richard Gethin como diretor em 05/12/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Louis Javier Falero como diretor em 05/12/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mrs Maria Milagros Lopez Simon em 25/06/2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2021 | 32 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 14/04/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Detalhes do secretário alterados para Hcp Management Services Limited em 23/04/2021 | 1 páginas | CH04 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2020 | 34 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 14/04/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2019 | 34 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 14/04/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 30 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Jamie Pritchard como diretor em 30/04/2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mrs Maria Milagros Lopez Simon como diretor em 30/04/2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Johannes Petrus Heemelaar como diretor em 30/04/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de David Richard Bradbury como diretor em 30/04/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 14/04/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O Hcp Management Services Ibex House (4th Floor West) 42-47 Minories London EC3N 1DY para 8 White Oak Square London Road Swanley Kent, England BR8 7AG | 1 páginas | AD02 | ||
Quem são os diretores de UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERCITY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretário | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent United Kingdom |
| 183851690004 | ||||||||||
FALERO, Louis Javier | Diretor | 1 Gresham Street EC2V 7BX London 4th Floor United Kingdom | England | British | Director | 301858300001 | ||||||||
GORDON, John Stephen | Diretor | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | Director | 203724200001 | ||||||||
LOVE, Brian | Diretor | EH3 8EG Edinburgh Caledonian Exchange, 19a Canning Street United Kingdom | Scotland | British | Director | 192017440001 | ||||||||
RAE, Neil, Mr. | Diretor | Park Avenue East Sheen SW14 8AT London 1 United Kingdom | England | British | Company Director | 119437600003 | ||||||||
BATESON, Anne Rosalind | Secretário nomeado | High Trees Great Holland CO13 0HZ Frinton On Sea Essex | British | 900007490001 | ||||||||||
BROOKS, Sally Ann | Secretário | 21 Clos Sant Teilo Llangyfelach SA5 7HG Swansea West Glamorgan | British | 47927300002 | ||||||||||
CURTIS, Richard Gregory | Secretário | 92 Beacons Park LD3 9BQ Brecon Powys | British | 34503940003 | ||||||||||
GEORGE, John Philip | Secretário | 11 Nantfawr Road CF23 6JQ Cardiff South Glamorgan | British | 72272750003 | ||||||||||
HEDGES, Teresa Sarah | Secretário | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent | 220688950001 | |||||||||||
LEWIS, Maria | Secretário | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 172959810001 | ||||||||||
MCCORMACK, James Joseph | Secretário | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | Company Secretary | 678610003 | |||||||||
MILLER, Roger Keith | Secretário | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 120645920001 | ||||||||||
MILLER, Roger Keith | Secretário | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||||||
NAYLOR, Philip | Secretário | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 201584350001 | |||||||||||
SHELL, Peter Geoffrey | Secretário | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||||||
SHELL, Peter Geoffrey | Secretário | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||||||
SWIFT, Anthony Alec | Secretário | 7 Roughley Farm Road Four Oaks B75 5TY Sutton Coldfield West Midlands | Other | 31352540002 | ||||||||||
ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Secretário | 3rd Floor 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff South Glamorgan | 114724080001 | |||||||||||
ARMSTRONG, James | Diretor | Olde Tyles Camp Road SL9 7PE Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Accountant | 41035300001 | |||||||||
BARRAS, Florence Marie Francoise | Diretor | 14 Rydon Street N1 7AL London | England | British,French | Director | 58686720001 | ||||||||
BARRON, Edward Graham | Diretor | 1a The Parklands Finchfield WV3 9DG Wolverhampton West Midlands | England | British | Director | 26181670001 | ||||||||
BIRCH, Alan Edward | Diretor | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor England And Wales United Kingdom | England | British | Company Director | 90700330002 | ||||||||
BRADBURY, David Richard | Diretor | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent | United Kingdom | British | Senior Investment Manager | 109853290002 | ||||||||
CORPETTI, Christian Lucien | Diretor | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent | United Kingdom | French | Portfolio Financial Controller | 163752540002 | ||||||||
COTTRELL, Keith | Diretor | Marble Hall Tregare NP5 4DT Monmouth Gwent | British | Civil Engineer | 23820430001 | |||||||||
COULDREY, Peter Alan James | Diretor | The Spinney Beechway GU1 2TA Guildford Surrey | British | Civil Engineer | 99321840001 | |||||||||
CREMIEUX, Pierre Michel | Diretor | 32 Avenue De L'Observateue 75014 Paris France | French | Company Director | 44182090001 | |||||||||
DAWSON, Nicholas Cobbett | Diretor | Beech House Cromwell Gardens SL7 1BG Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Civil Servant | 3792100001 | ||||||||
DAWSON, Nicholas Cobbett | Diretor | Beech House Cromwell Gardens SL7 1BG Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Civil Engineer | 3792100001 | ||||||||
DOUGHTY, William Robert | Diretor | 10 Brookmans Avenue Brookmans Park AL9 7QJ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | Investment Banker | 141397620001 | ||||||||
GETHIN, Ian Richard | Diretor | 1 Gresham Street EC2V 7BX London St Martins House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Banker | 91224510003 | ||||||||
GETHIN, Ian Richard | Diretor | Gresham Street EC2V 7BX London St Martins House 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Banker | 91224510003 | ||||||||
GILBEY, Hannah | Diretor | 14 Dane Park CM23 2PR Bishops Stortford Hertfordshire | British | Investment Director | 78180430001 | |||||||||
HEEMELAAR, Johannes Petrus | Diretor | Kingsway WC1B 6AN London 1 England | Netherlands | Dutch | Director | 146317070001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de UK HIGHWAYS M40 LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uk Highways M40 (Holdings) Limited | 06/04/2016 | White Oak Square, London Road BR8 7AG Swanley 8 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
UK HIGHWAYS M40 LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Supplemental debenture | Criado em 16/10/2001 Entregue em 25/10/2001 | Pendente | Montante garantido All present and future obligations and liabilities of the company or holdings to any finance party or bank hedge provider under each finance document and hedging agreement to which either the company or holdings is a party and all present and future obligations and liabilities included in the definition of secured liabilities in the share mortgage under clauses 9.7, 13 and 18.4 of the share mortgage (all terms as defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage (and incorporating all the terms and conditions of a debenture dated the 8TH october 1996 (the "debenture") and made between the company and the "security trustee") | Criado em 27/09/2000 Entregue em 03/10/2000 | Pendente | Montante garantido All monies obligations and liabilites covenanted to be paid or discharged by the company to any secured creditor under any secured document (together "the secured obligations") | |
Breve descrição The l/h property k/a handy cross maintenance depot more particularly described in a lease dated 8 june 2000. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage incorporating all the terms and conditions of a debenture dated 8TH october 1996 | Criado em 06/06/2000 Entregue em 21/06/2000 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to any secured creditor under any secured document ("the secured obligations") | |
Breve descrição L/H property k/a handy cross maintenance depot. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/01/1998 Entregue em 26/01/1998 | Pendente | Montante garantido All monies obligations and liabilites covenanted to be paid or discharged by the company to any secured creditor under any secured document (together "the secured obligations") | |
Breve descrição L/H land in the county of oxfordshire district of cherwell on the west side of wildmere road banbury t/n ON195734 and all buildings and fixtures (including trade fixtures). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 08/10/1996 Entregue em 21/10/1996 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under any secured document (as defined therein) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of legal charge | Criado em 08/10/1996 Entregue em 09/10/1996 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the charged retention account | |
Breve descrição By way of first legal charge the account (the charged retention account) held or to be held in the name of the secretary of state and the dbfo co and all sums standing to the credit of such account and any accrued interest on such sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0