PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED

PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03048528
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    • (3410) /

    Onde fica PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ASSETCO PAPWORTH LIMITED23/03/200423/03/2004
    ADVANCED TRANSPORT TECHNOLOGY LIMITED21/04/199521/04/1995

    Quais são as últimas contas de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/09/2011
    Próximas contas vencem em30/06/2012
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2010

    Qual é o status da última declaração de confirmação para PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até21/04/2017
    Próxima declaração de confirmação vence05/05/2017
    VencidoSim

    Qual é o status da última declaração anual para PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    2 páginasF10.2

    Parte do bem ou empresa foi libertada da garantia 9

    5 páginasMR05

    Parte do bem ou empresa foi libertada da garantia 8

    5 páginasMR05

    Ordem do tribunal para liquidar

    2 páginasCOCOMP

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Mark Clissett como diretor

    1 páginasTM01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/03/2011 para 30/09/2011

    1 páginasAA01

    Término da nomeação de Philip Mcdaid como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 21/04/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital11/10/2011

    Estado do capital em 11/10/2011

    • Capital: GBP 60,000
    SH01

    Nomeação de Continental Shelf 548 Limited como diretor

    3 páginasAP02

    Nomeação de Continental Shelf 547 Limited como diretor

    3 páginasAP02

    Término da nomeação de Scott Brown como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Philip Mcdaid como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Scott Brown como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Mark Anthony Clissett como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Marcus Shannon como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2010

    17 páginasAA

    Término da nomeação de Ricahrd Fulton como secretário

    2 páginasTM02

    Nomeação de Scott Brown como secretário

    3 páginasAP03

    Término da nomeação de Raymond Flynn como diretor

    2 páginasTM01

    Nomeação de Scott Douglas Brown como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Ricahrd Fulton como secretário

    3 páginasAP03

    Término da nomeação de Michael Lavender como secretário

    2 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 21/04/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    A deed of accession 09/02/2010
    RES13

    Quem são os diretores de PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CONTINENTAL SHELF 547 LIMITED
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Diretor
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro7669797
    163247510001
    CONTINENTAL SHELF 548 LIMITED
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Diretor
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro7669811
    163247580001
    BROWN, Scott
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Secretário
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Australian154943660001
    FAIERS, Colin Charles
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    Secretário
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    British157295550001
    FULTON, Ricahrd
    Arthur Street
    BT1 4GA Belfast
    21
    Antrim
    Secretário
    Arthur Street
    BT1 4GA Belfast
    21
    Antrim
    British154196160001
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Secretário
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    LAVENDER, Michael David
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    Secretário
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    British149181030001
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Secretário
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    British45962560004
    MATTHEWS, Michael James
    11 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    Secretário
    11 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    British9389260001
    WATSON, Philip George
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    Secretário
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    British42944690001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretário nomeado
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    SARCON COMPLIANCE LIMITED
    Murray House
    Murray Street
    BT1 6DN Belfast
    Antrim
    Secretário
    Murray House
    Murray Street
    BT1 6DN Belfast
    Antrim
    143646650001
    BROWN, Scott Douglas
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Diretor
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    EnglandAustralian183542790001
    CLISSETT, Mark Anthony
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Diretor
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    United KingdomBritish159159010001
    EDDY, Jonathan Charles Grenville
    Heath House
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    Diretor
    Heath House
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    British72062400003
    FAIERS, Colin Charles
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    Diretor
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    United KingdomBritish157295550001
    FLYNN, Raymond Francis
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Diretor
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish119131330001
    HOUSDEN, Malcolm Brian
    16 The Woodlands
    Broom
    SG18 9NH Biggleswade
    Bedfordshire
    Diretor
    16 The Woodlands
    Broom
    SG18 9NH Biggleswade
    Bedfordshire
    British31969440001
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Diretor
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    United KingdomBritish45962560004
    MCDAID, Philip
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    United Kingdom
    Diretor
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomIrish161036530001
    MELLON, Denis
    19 Homewood Road
    AL1 4BG St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    19 Homewood Road
    AL1 4BG St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish105707560001
    OLIVE, Michael Pelham Morris, Mr.
    Church Farm House
    Lower Basildon
    RG8 9NH Pangbourne
    Berkshire
    Diretor
    Church Farm House
    Lower Basildon
    RG8 9NH Pangbourne
    Berkshire
    EnglandBritish36404130004
    REILLY, Paul
    Sonning Mead
    Thames Street
    RG4 6UR Sonning
    Berkshire
    Diretor
    Sonning Mead
    Thames Street
    RG4 6UR Sonning
    Berkshire
    United KingdomBritish67639350002
    SCOTT, George Douglas
    Hill Farm House
    Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Diretor
    Hill Farm House
    Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    British76708940001
    SHANNON, Marcus John
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    Diretor
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    United KingdomBritish108366960001
    SMITH, David Michael
    9 Crowdon Drive
    CV32 6NX Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    Diretor
    9 Crowdon Drive
    CV32 6NX Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    British119131400001
    WATSON, Philip George
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    Diretor
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    British42944690001
    WESTBURY, Peter
    Somerset Hill
    Holmbury St Mary
    RH5 6NR Dorking
    Surrey
    Diretor
    Somerset Hill
    Holmbury St Mary
    RH5 6NR Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish2193910001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Diretor nomeado
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 01/10/2008
    Entregue em 16/10/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/10/2008Registro de uma garantia (395)
    • 11/09/2013Parte do imóvel ou empresa foi liberada da garantia (MR05)
    Mortgage debenture
    Criado em 05/10/2005
    Entregue em 12/10/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from sarcon vehicles limited to the chargee
    Breve descrição
    The property k/a unit 1 papworth business park papworth everard cambridge & units 3/5 papworth business park papworth everard cambridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transações
    • 12/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 11/09/2013Parte do imóvel ou empresa foi liberada da garantia (MR05)
    Mortgage deed
    Criado em 01/11/2004
    Entregue em 03/11/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a unit 5, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 03/11/2004Registro de uma garantia (395)
    • 14/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage deed
    Criado em 01/11/2004
    Entregue em 03/11/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a unit 3, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 03/11/2004Registro de uma garantia (395)
    • 14/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage deed
    Criado em 09/03/2000
    Entregue em 11/03/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property being unit 3,papworth business park,cambridge.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 11/03/2000Registro de uma garantia (395)
    • 21/05/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    All assets debenture
    Criado em 11/08/1999
    Entregue em 14/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 14/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 07/07/1999
    Entregue em 15/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 15/07/1999Registro de uma garantia (395)
    • 14/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/05/1995
    Entregue em 13/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an acquisition agreement dated 10 may 1995 or this debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Papworth Trust
    Transações
    • 13/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 01/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/05/1995
    Entregue em 06/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 20/08/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/06/2013Data da petição
    19/08/2013Início da liquidação
    Liquidação compulsória
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profissional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0