CAMBUS HOLDINGS LIMITED

CAMBUS HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCAMBUS HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03051451
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CAMBUS HOLDINGS LIMITED?

    • Outro transporte terrestre de passageiros urbano, suburbano ou metropolitano (não metro, metropolitano ou sistemas similares) (49319) / Transportes e armazenagem

    Onde fica CAMBUS HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CAMBUS HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LEGISLATOR 1241 LIMITED01/05/199501/05/1995

    Quais são as últimas contas de CAMBUS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/04/2012

    Quais são as últimas submissões para CAMBUS HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaração anual preparada até 01/05/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/05/2013

    Estado do capital em 07/05/2013

    • Capital: GBP .025
    SH01

    Término da nomeação de Leslie Brian Warneford como diretor em 26/04/2013

    1 páginasTM01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 01/02/2013

    • Capital: GBP 0.025
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 30/04/2012

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/05/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/04/2011

    13 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    7 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Declaração anual preparada até 01/05/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/04/2010

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/05/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Michael John Vaux em 10/10/2009

    1 páginasCH03

    Contas anuais preparadas até 30/04/2009

    12 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Leslie Brian Warneford em 01/11/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Colin Brown em 15/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Michael John Vaux em 07/10/2009

    1 páginasCH03

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    Quem são os diretores de CAMBUS HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Secretário
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Diretor
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Secretário
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    British27890500005
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Secretário
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Secretário
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Secretário
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    British54321810002
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Secretário nomeado
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    British900008180001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Secretário
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    British1817090001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secretário
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secretário
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Diretor
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    British27890500005
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Diretor
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Diretor
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    EDEN, Philip Brookes, Mr.
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    Diretor
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritish63838120003
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Diretor
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Diretor
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GREDLEY, William Jerome
    Unex House
    Church Lane
    Stetchworth, Newmarket
    Cambridgeshire
    Diretor
    Unex House
    Church Lane
    Stetchworth, Newmarket
    Cambridgeshire
    British45017360002
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Diretor
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Diretor
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    British45901180002
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Diretor
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    British54321810002
    HOWITT, Malcolm
    36 Castlereagh
    Wynyard Park
    TS22 5QF Billingham
    Diretor
    36 Castlereagh
    Wynyard Park
    TS22 5QF Billingham
    British14928120002
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Diretor
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    MARSHALL, Diana Jane
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    Diretor
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    British47799990002
    MERRYWEATHER, Paul Anthony
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    Diretor
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    British10329770001
    NORWELL, Philip Ben
    74 St. Peter Road
    Oundle
    PE8 4NY Peterborough
    Diretor
    74 St. Peter Road
    Oundle
    PE8 4NY Peterborough
    British45017370001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Diretor nomeado
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    British900008180001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Diretor
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Diretor
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    British1817090001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Diretor
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STEEL, John Bell
    11 Perry Court
    Clerk Maxwell Road
    CB3 0RS Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    11 Perry Court
    Clerk Maxwell Road
    CB3 0RS Cambridge
    Cambridgeshire
    British10329790004
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Diretor
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    WARNER, Barry Alfred
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    British37224390001

    CAMBUS HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Floating charge
    Criado em 29/11/1996
    Entregue em 19/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee,the banks,the issuing bank and the overdraft bank (all as defined) under the charge,the agreement and under any of the other finance documents (as defined) and/or any deed or document supplemental thereto
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Security Trustee for the Banks
    Transações
    • 19/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 16/04/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 15/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Floating charge
    Criado em 30/09/1996
    Entregue em 12/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under the agreement and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without prejudice to the foregoing generality, all obligations to indemnify the chargee (the "secured liabilities") provided that the expression secured liabilites shall not include any relevant liabilities of the company
    Breve descrição
    (1) as security for the payment of all secured liabilities, the chargor with full title guarantee charges in favour of the chargee for itself and as agent and security trustee aforesaid by way of floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Agent and Security Trustee for and on Behalf of the Banks, the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transações
    • 12/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 15/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Floating charge
    Criado em 02/02/1996
    Entregue em 17/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto
    Breve descrição
    By way of floating charge all its undertaking property assets and rights present and future.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Security Trustee for and on Behalf of the Banks, the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transações
    • 17/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 16/04/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 15/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 13/10/1995
    Entregue em 26/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due from the company (formerly known as legislator 1241 limited) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Cowley road road cambridge t/no CB62831 depot road newmarket suffolk t/no SK89061 lincoln road peterborough cambs t/no CB65229 kilmaine close cambs t/no CB7898 and CB111779. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 26/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 28/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0