FTM TYREFIT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaFTM TYREFIT LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03078330
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de FTM TYREFIT LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica FTM TYREFIT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Yorkshire
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de FTM TYREFIT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    FTM LIMITED03/10/199503/10/1995
    APPLYGENTLE LIMITED11/07/199511/07/1995

    Quais são as últimas contas de FTM TYREFIT LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para FTM TYREFIT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 05/07/2012

    • Capital: GBP 2,184,155.00
    4 páginasSH01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Allotment of 2,184153 shares 28/09/2012
    RES13

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 24/04/1998

    • Capital: GBP 2,184,155.00
    4 páginasSH01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Declaração anual preparada até 11/03/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2011 para 31/03/2012

    1 páginasAA01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    4 páginasAA

    Nomeação de Mr Kazushi Ogura como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Mr Kenji Murai como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Michael Healy como secretário

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Ian Fraser como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Michael Healy como diretor

    2 páginasTM01

    Nomeação de Ian Vincent Ellis como secretário

    3 páginasAP03

    Declaração anual preparada até 11/03/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    4 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de 3 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB em 02/08/2010

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 11/03/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Michael Joseph Anthony Healy em 20/10/2009

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Michael Joseph Anthony Healy em 20/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Ian Ellis Fraser em 20/10/2009

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    4 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    Quem são os diretores de FTM TYREFIT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ELLIS, Ian Vincent
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    British162127580001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese150485750001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Secretário
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    JAMES, Martyn Keith
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    Secretário
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    British10697770001
    JUDDERY, John William Henry
    Apartment 11 High Point
    76 Bournemouth Road
    BH14 0EY Poole
    Dorset
    Secretário
    Apartment 11 High Point
    76 Bournemouth Road
    BH14 0EY Poole
    Dorset
    British5986560001
    MASKELL, Philip John
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretário
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British5733160003
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Secretário
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretário
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BATESON, Dominic Clive
    2 Norden Meadows
    SL6 4SB Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    2 Norden Meadows
    SL6 4SB Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish98910740001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Diretor
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    BRIDGMAN, Michael
    Broomfield Lodge Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    Diretor
    Broomfield Lodge Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    British74833800001
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Diretor
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUk28393850006
    HARRIS, Frances
    19 Herm Road
    Parkstone
    BH12 4LE Poole
    Dorset
    Diretor
    19 Herm Road
    Parkstone
    BH12 4LE Poole
    Dorset
    British46118500001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Diretor
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish99111340001
    HOLMES, Peter Robert
    Kerfield Cottage Innerleithen Road
    EH45 8BG Peebles
    Peeblesshire
    Diretor
    Kerfield Cottage Innerleithen Road
    EH45 8BG Peebles
    Peeblesshire
    British28829540001
    JAMES, Martyn Keith
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    Diretor
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    British10697770001
    LEWIS, Ivor
    6 Wentworth Close
    WA8 9JF Widnes
    Cheshire
    Diretor
    6 Wentworth Close
    WA8 9JF Widnes
    Cheshire
    British34800310001
    LOCHERY, Anthony Francis
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    EnglandBritish18996670003
    MASKELL, Philip John
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish5733160003
    MASON, Dale John
    17 Springdale Road
    BH18 9BN Broadstone
    Dorset
    Diretor
    17 Springdale Road
    BH18 9BN Broadstone
    Dorset
    British10697780002
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Diretor
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Diretor
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    American75755850002
    PARKER, Kevin Neil
    2 Guy Close
    Stapleford
    NG9 7GZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    2 Guy Close
    Stapleford
    NG9 7GZ Nottingham
    Nottinghamshire
    British45659780001
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Diretor
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish126476060001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    FTM TYREFIT LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Composite guarantee and charge
    Criado em 12/04/2000
    Entregue em 27/04/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries (as defined)) (the "security trustee") and all costs charges and expenses properly incurred by the chargee in connection with the preparation and negotiation of the banking documents
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 27/04/2000Registro de uma garantia (395)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 04/12/1999
    Entregue em 10/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All present and future right title and interest in the plant machinery chattels or other equipment described in schedule 2 to the mortgage the benefit of any guarantee warranty or other obligations in relation to the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge over account balances
    Criado em 04/12/1999
    Entregue em 10/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All monies from time to time held to the credit of each company listed in schedule 1 to the deed by the bank on any current deposit or other account or accounts which the company may have with lloyds tsb bank PLC.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of adherence to a composite guarantee and debenture (the "original debenture")
    Criado em 24/04/1998
    Entregue em 09/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise and under the terms of the "original debenture"
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Rbs Mezzanine Limited
    Transações
    • 09/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 9 august 1996 and
    Criado em 24/04/1998
    Entregue em 09/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness,liabilities and obligations which are due or to become due from any group company to the security beneficiaries in any manner whatsoever whether pursuant to the guarantee or otherwise including all liabilities incurred by the security beneficiaries at the request of any group company in connection with foreign exchange transactions,acceptances,discounting or otherwise or under guarantees,bonds,indemnities,documentary or other credits or any instruments whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transações
    • 09/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 17/07/1996
    Entregue em 22/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 22/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 08/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0