PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED

PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03085817
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Serviços de representação de mídia (73120) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    7th Floor, Lacon House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    EUROLITE 6'S LIMITED06/09/199506/09/1995
    MICROPRIZE LIMITED31/07/199531/07/1995

    Quais são as últimas contas de PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2021

    Quais são as últimas submissões para PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Término da nomeação de Leon Taviansky como diretor em 31/03/2022

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2021

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Anthony John Booker como diretor em 15/02/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Jason Richard Cotterrell como diretor em 15/02/2021

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Leon Taviansky como diretor em 15/02/2021

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2020

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Naren Anirudha Patel como diretor em 30/04/2020

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony John Booker em 18/01/2020

    2 páginasCH01

    Alteração dos detalhes de Primesight Limited como pessoa com controlo significativo em 30/12/2019

    2 páginasPSC05

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Primesight Limited como pessoa com controlo significativo em 30/12/2019

    2 páginasPSC05

    Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony John Booker em 10/01/2020

    2 páginasCH01

    Alteração dos detalhes de Primesight como pessoa com controlo significativo em 30/12/2019

    2 páginasPSC05

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2019

    6 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Primesight Limited the Met Building 22 Percy Street London W1T 2BU para 7th Floor, Lacon House 84 Theobalds Road London WC1X 8NL em 07/11/2019

    1 páginasAD01

    Alteração dos detalhes de Primesight como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    5 páginasPSC05

    Nomeação de Mr Anthony John Booker como diretor em 15/07/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Darren David Singer como diretor em 15/07/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Monica Ellen Mackinnon como secretário em 30/06/2019

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Matthew Guy Teeman como diretor em 30/06/2019

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COTTERRELL, Jason Richard
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Diretor
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    United KingdomBritish247876600001
    SINGER, Darren David
    Leicester Square
    WC2H 7LA London
    30
    United Kingdom
    Diretor
    Leicester Square
    WC2H 7LA London
    30
    United Kingdom
    EnglandBritish159918310001
    CLARK, Peter Ian
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    Secretário
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    New Zealander64941070001
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Secretário
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    British77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Secretário
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    DESAI, Falguni
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    Secretário
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    British77755390001
    MACKINNON, Monica Ellen
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    Secretário
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    British107899210001
    PHILIP, Ian Edward
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    Secretário
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    British10317680001
    PINNELL, Judith Helen
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    Secretário
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    British127121950001
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    Secretário
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    British118367070001
    WHITE, Leonard Henry
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    Secretário
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    British12308620001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOOKER, Anthony John
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Diretor
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    United KingdomBritish123183570001
    CLARK, Peter Ian
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    Diretor
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    New Zealander64941070001
    DANIELS, Charles James
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    British69233900002
    DANIELS, Paul Jonathan
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    Diretor
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    EnglandBritish127121890001
    DANIELS, Paul Jonathan
    12 Beechwood Close
    GU51 5PT Church Crookham
    Hampshire
    Diretor
    12 Beechwood Close
    GU51 5PT Church Crookham
    Hampshire
    British99302630001
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Diretor
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritish61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish42787120004
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Diretor
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    PATEL, Naren Anirudha
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Diretor
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    EnglandBritish44514540003
    PATEL, Naren Anirudha
    Langham
    Brokengate Lane, Denham
    UB9 4LA Uxbridge
    Middlesex
    Diretor
    Langham
    Brokengate Lane, Denham
    UB9 4LA Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish44514540002
    PEARSON, Sarah
    Flat 11 29-31 Dingley Place
    EC1V 8BR London
    Diretor
    Flat 11 29-31 Dingley Place
    EC1V 8BR London
    British49285200002
    PHILIP, Ian Edward
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish10317680001
    SINGH, Sohan
    The Hollies
    Castle Road Horsell
    GU21 4ET Woking
    Surrey
    Diretor
    The Hollies
    Castle Road Horsell
    GU21 4ET Woking
    Surrey
    EnglandBritish82811080001
    TAVIANSKY, Leon
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Diretor
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    United KingdomBritish216429060001
    TEEMAN, Matthew Guy
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    Diretor
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    EnglandBritish227376180001
    WATT, William George
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    Diretor
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    ScotlandBritish72664400006
    WOODWARD, Robert Stanley Lawrence
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    Diretor
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    ScotlandBritish122562020001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quem são as pessoas com controle significativo de PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Gmt Realisation Fund L.P.
    Les Banques
    St. Peter Port
    GY1 2JA Guernsey
    Trafalar Court
    Guernsey
    05/04/2017
    Les Banques
    St. Peter Port
    GY1 2JA Guernsey
    Trafalar Court
    Guernsey
    Sim
    Forma jurídicaLimited Partnership
    País de registroGuernsey
    Autoridade legalLimited Liability Partnership Act
    Local de registroGuernsey Register
    Número de registroLp2788
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.
    Primesight Limited
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    England
    06/04/2016
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro1847728
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Composite debenture
    Criado em 22/10/2012
    Entregue em 26/10/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking assets present and future, including goodwill, book and other debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Macquarie Us Trading Llc
    Transações
    • 26/10/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 04/05/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Full form debenture
    Criado em 16/11/2011
    Entregue em 23/11/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Leumi Abl Limited
    Transações
    • 23/11/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/11/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Security agreement
    Criado em 04/04/2003
    Entregue em 16/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent on Trust for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 16/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 25/11/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement
    Criado em 18/07/2002
    Entregue em 24/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 24/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 10/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 02/06/1997
    Entregue em 11/06/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness, liabilities and obligations which are as at 2ND june 1997 or may at any time thereafter be due, owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee, by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descrição
    First fixed and floating charges over the undertaking and all its property and assets present and future incuding its goodwill and uncalled capital and all plant and machinery. (N.B. the property described in part I and ii of the schedule attached to this form 395 is described as being "none").. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Bank")
    Transações
    • 11/06/1997Registro de uma garantia (395)
    • 18/06/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 30/09/1996
    Entregue em 07/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 14/06/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Stock trust deed
    Criado em 30/09/1996
    Entregue em 05/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All amounts from time to time due from the company to the chargee (as trustees) under the stock trust deed including but not limited to payment of the amount of the principal sum then outstanding on the security of the stock and interest on the amount of such principal sum for the time being outstanding at the rate of 10% per year payable half yearly on 31ST december and 30TH june in the years 1996, 1997 and 1998 but at 12% per year in 1999 and 14% in 2000
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Botts Capital Nominees Limited and David Martin-Jenkins
    Transações
    • 05/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 20/12/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 30/09/1996
    Entregue em 05/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Primesight PLC
    Transações
    • 05/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 20/12/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0