EMPRISE PLC
Visão geral
Nome da empresa | EMPRISE PLC |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade anónima cotada |
Número da empresa | 03089450 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Sim |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de EMPRISE PLC?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica EMPRISE PLC?
Endereço do escritório registrado | Gateway House Tollgate, Chandlers Ford SO53 3TG Eastleigh Hampshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de EMPRISE PLC?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
EMPRISE LIMITED | 02/05/2007 | 02/05/2007 |
EMPRISE PLC | 21/10/2004 | 21/10/2004 |
EMPRISE LIMITED | 02/11/1995 | 02/11/1995 |
INGLEBY (835) LIMITED | 09/08/1995 | 09/08/1995 |
Quais são as últimas contas de EMPRISE PLC?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 29/06/2016 |
Quais são as últimas submissões para EMPRISE PLC?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores | 3 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/07/2019 | 31 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Estado de situação patrimonial | 8 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG para Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG em 17/07/2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 186 City Road London EC1V 2NT para Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG em 17/07/2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Término da nomeação de Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited como secretário em 16/07/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 29/06/2017 para 29/12/2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Nomeação de Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited como secretário em 01/09/2017 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Ronald Sydney Beadle como secretário em 01/09/2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 030894500005 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 05/08/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 29/06/2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior encurtado de 30/06/2016 para 29/06/2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark Ronald Sydney Beadle como diretor em 01/04/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark Ronald Sydney Beadle como secretário em 01/04/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Howard Graham Sharp como secretário em 01/04/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 05/08/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Howard Graham Sharp como diretor em 01/04/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais modificadas preparadas até 30/06/2015 | 12 páginas | AAMD | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/06/2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Howard Graham Sharp em 03/08/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Quem são os diretores de EMPRISE PLC?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRETT, Stephen John | Diretor | Tollgate, Chandlers Ford SO53 3TG Eastleigh Gateway House Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 5149580003 | ||||||||
BEADLE, Mark Ronald Sydney | Diretor | Tollgate, Chandlers Ford SO53 3TG Eastleigh Gateway House Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 198215750001 | ||||||||
BEADLE, Mark Ronald Sydney | Secretário | 186 City Road London EC1V 2NT | 214739420001 | |||||||||||
BURROWS, Alison Jane | Secretário | 186 City Road London EC1V 2NT | British | 166193310001 | ||||||||||
CROWFOOT, Martyn Christopher | Secretário | 186 City Road London EC1V 2NT | British | Director | 85033580002 | |||||||||
SHARP, Howard Graham | Secretário | 186 City Road London EC1V 2NT | 187487590001 | |||||||||||
SHARP, Howard Graham | Secretário | Ridgefield 21 Blackmore Way Blackmore End AL4 8LJ Wheathampstead Hertfordshire | British | 38254450003 | ||||||||||
ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED | Secretário | Canning Street EH3 8EH Edinburgh Exchange Tower, 19 Scotland |
| 665080009 | ||||||||||
INGLEBY NOMINEES LIMITED | Secretário nomeado | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||||||
BARRETT, Stephen John | Diretor | Amberley Lee's Hill RG29 1RQ South Warnborough Hampshire | British | Director | 5149580002 | |||||||||
BENCE, Trevor William | Diretor | 4 Chawkmare Coppice Aldwick PO21 3BT Bognor Regis West Sussex | England | British | Director | 46424570001 | ||||||||
BURROWS, Alison Jane | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | Director | 123013760002 | ||||||||
BURROWS, Alison Jane | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | Chartered Accountant | 123013760002 | ||||||||
CLAMPIT, Diane | Diretor | 99 Chepstow Road NN18 8QQ Corby Northamptonshire | British | Director | 105578650002 | |||||||||
CLARKE, Raymond James | Diretor | Sunnybank Hickmans Green, Boughton Under Blean ME13 9NT Faversham Kent | British | Director | 58678170002 | |||||||||
CROWFOOT, Martyn Christopher | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | Director | 85033580002 | ||||||||
FURLONG, David | Diretor | Forest Edge 18 Sylvan Way IG7 4QB Chigwell Essex | British | Director | 96183490001 | |||||||||
FURLONG, David | Diretor | Forest Edge 18 Sylvan Way IG7 4QB Chigwell Essex | British | Director | 96183490001 | |||||||||
GARRETT, Michael Stephan | Diretor | Wood Lodge Lughorse Lane, Yalding ME18 6EB Maidstone Kent | United Kingdom | British | Director | 70619210003 | ||||||||
HAMPSON, Anthony Peter | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | Uk | British | Director | 138791270001 | ||||||||
HARVEY, Paul | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | Director | 175308800001 | ||||||||
HOWIE, Alison Jane | Diretor | 37 Lavengro Road West Norwood SE27 9EQ London | British | Director | 96185200001 | |||||||||
MCGILVRAY, Craig Matthew | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | Scotland | British | Director | 58993260002 | ||||||||
MOODY, Lee Mark | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | United Kingdom | British | Director | 114275100001 | ||||||||
POSKITT, John Robert | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | United Kingdom | British | Company Director | 92122220001 | ||||||||
ROGERS, Martin Phillip | Diretor | 28 Fairfax Road NW6 4HA London | British | Director | 18752390002 | |||||||||
RUSSELL, Christopher John | Diretor | 37 Glebe Street Chiswick W4 2BE London | British | Director | 96185690001 | |||||||||
SHARP, Howard Graham | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | Chartered Accountant | 38254450005 | ||||||||
SHARP, Howard Graham | Diretor | Ridgefield 21 Blackmore Way Blackmore End AL4 8LJ Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 38254450003 | ||||||||
SHEARMAN, Lesley | Diretor | 186 City Road London EC1V 2NT | United Kingdom | British | Director | 82540740002 | ||||||||
WALKER, James Newman | Diretor | 39 Coverside Road LE8 9EB Leicester Leicestershire | England | British | Director | 126676230001 | ||||||||
WEBSTER, Richard Edward | Diretor | 1 Larkswood Road Corringham SS17 9DG Stanford-Le-Hope Essex | British | Director | 116347910001 | |||||||||
WEBSTER, Richard Edward | Diretor | 1 Larkswood Road Corringham SS17 9DG Stanford-Le-Hope Essex | British | Director | 116347910001 | |||||||||
WHITTINGHAM, Ian Clive | Diretor | Swan Mews RG29 1DL North Warnborough 7 Hampshire | United Kingdom | British | Director | 151458200001 | ||||||||
INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Diretor nomeado | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de EMPRISE PLC?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emprise Holdings Limited | 06/04/2016 | City Road EC1V 2NT London 186 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
EMPRISE PLC possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Criado em 12/04/2013 Entregue em 26/04/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Notification of addition to or amendment of charge. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Composite guarantee and debenture | Criado em 14/05/2007 Entregue em 19/05/2007 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from any obligor or other member of the group to any of the senior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge of securities | Criado em 30/09/2004 Entregue em 07/10/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 19/07/2001 Entregue em 26/07/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 31/10/1995 Entregue em 09/11/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company (formerly known as ingleby (835) limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
EMPRISE PLC possui casos de insolvência?
Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidação voluntária de credores |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0