SOLOR CARE HOMES LTD
Visão geral
Nome da empresa | SOLOR CARE HOMES LTD |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 03092133 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SOLOR CARE HOMES LTD?
- Atividades de cuidados residenciais para idosos e pessoas com deficiência (87300) / Atividades de saúde humana e ação social
Onde fica SOLOR CARE HOMES LTD?
Endereço do escritório registrado | Voyage Care Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SOLOR CARE HOMES LTD?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
ROBINIA CARE HOMES LIMITED | 11/09/1995 | 11/09/1995 |
TEMPLECO 270 LIMITED | 17/08/1995 | 17/08/1995 |
Quais são as últimas contas de SOLOR CARE HOMES LTD?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2014 |
Qual é o status da última declaração anual para SOLOR CARE HOMES LTD?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para SOLOR CARE HOMES LTD?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 30/06/2015 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado do capital em 09/04/2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Philip Andre Sealey como diretor em 09/01/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Kevin Wei Roberts como diretor em 09/01/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2014 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 30/06/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2013 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD* em 25/09/2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Kevin Wei Roberts como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Bruce Mckendrick como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 30/06/2013 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 28 páginas | MG01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2012 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 30/06/2012 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Bruce Mckendrick como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Andrew Winning como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Philip Sealey como secretário | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Christina Bailey como secretário | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Quem são os diretores de SOLOR CARE HOMES LTD?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEALEY, Philip | Secretário | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | British | 168863700001 | ||||||
SEALEY, Philip Andre | Diretor | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire | England | British | Company Secretary | 45325360001 | ||||
WINNING, Andrew | Diretor | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | England | British | None | 73772160002 | ||||
ARTHUR, Simon David | Secretário | 128 The Oaks RG14 7UZ Newbury Berkshire | British | Solicitor | 79790640004 | |||||
BAILEY, Christina | Secretário | Garrick House 2 Queen Street WS13 6QD Lichfield Staffordshire | 148286600001 | |||||||
BAKER, Michael Anthony | Secretário | 23 Polo Way Chesterfield CT5 3LA Whitstable Kent | British | Director | 44501470001 | |||||
DOLEMAN, Kit | Secretário | Priory Road West Bridgford NG2 5HU Nottingham 31 Nottinghamshire United Kingdom | British | Ceo | 135491940001 | |||||
FRY, David | Secretário | Woodbine Cottage Vale Of Health NW3 1AX London | British | Financial Director | 90720170001 | |||||
HARRISON, Adam Chapman | Secretário | 42 Marina Drive Staverton BA14 8UR Trowbridge Wiltshire | British | Finance Director | 77287140001 | |||||
MCGINN, Benjamin John | Secretário | 11 Maurice Road St Andrews BS6 5BZ Bristol | British | Financial Director | 61212620003 | |||||
SPOORS, Mark | Secretário | Carriage Court BA1 2PW Bath Banes | British | Finance Director | 120580980001 | |||||
TAYLOR, Timothy John | Secretário nomeado | 13 Dagden Road Shalford GU4 8DD Guildford Surrey | British | 900009360001 | ||||||
THORTON, Martin Hewson | Secretário | 18 Church Road Silverton EX5 4HS Exeter Devon | British | Solicitor | 84509000001 | |||||
WAGSTAFF, Elizabeth Anne | Secretário | 35 St James Square BA1 2TT Bath | British | 43422820002 | ||||||
BAINS, Satwant Singh | Diretor | 8 Waldemar Road Wimbledon SW19 7LJ London | British | Chief Executive Officer | 94530450001 | |||||
BAKER, Michael Anthony | Diretor | 23 Polo Way Chesterfield CT5 3LA Whitstable Kent | British | Director | 44501470001 | |||||
BALL, Julian Charles | Diretor | Mill Fleam Hilton DE65 5HE Derby 14 Derbyshire | England | British | Director | 138044110001 | ||||
BROOKES, Richard Dennis | Diretor | Cress Farm House High Street CV37 8EA Welford On Avon Warwickshire | England | British | Chart Surveyor | 81219580001 | ||||
DOLEMAN, Kit | Diretor | Priory Road West Bridgford NG2 5HU Nottingham 31 Nottinghamshire United Kingdom | England | British | Ceo | 135491940001 | ||||
DURRANCE, Philip Walter | Diretor nomeado | 34 Hamilton Gardens St Johns Wood NW8 9PU London | British | 900009350001 | ||||||
FORD, Katherine Frances | Diretor | Garrick House 2 Queen Street WS13 6QD Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 138136380001 | ||||
FRY, David | Diretor | Woodbine Cottage Vale Of Health NW3 1AX London | England | British | Financial Director | 90720170001 | ||||
HARRISON, Adam Chapman | Diretor | 42 Marina Drive Staverton BA14 8UR Trowbridge Wiltshire | British | Finance Director | 77287140001 | |||||
KING, Paul Dennis Arthur | Diretor | Mere Combe Farm Bath Road Blagdon BS18 6SG North Somerset | British | Accountant | 60873180001 | |||||
MCGINN, Benjamin John | Diretor | 11 Maurice Road St Andrews BS6 5BZ Bristol | United Kingdom | British | Finance Director | 61212620003 | ||||
MCKENDRICK, Bruce | Diretor | Garrick House 2 Queen Street WS13 6QD Lichfield Staffordshire | Uk | British | None | 157088060001 | ||||
PERRY, Roland Robert Joseph | Diretor | Race Farm Lane Kingston OX13 5AY Bagpuize Race Farm Oxfordshire | England | British | Director | 139021390001 | ||||
ROBERTS, Kevin Wei | Diretor | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | England | British | Company Director | 72030660002 | ||||
SPOORS, Mark | Diretor | Carriage Court BA1 2PW Bath Banes | British | Finance Director | 120580980001 | |||||
TAYLOR, Timothy John | Diretor nomeado | 13 Dagden Road Shalford GU4 8DD Guildford Surrey | British | 900009360001 | ||||||
VON MALACHOWSKI, Glen | Diretor | Canada Farm House Captains Hill BA9 6HA Kinwartin Alcester | England | British | Director | 66391980002 | ||||
WAGSTAFF, Elizabeth Anne | Diretor | Abbey Rectory Park Lane BA1 2XH Bath | British | Director | 43422820004 | |||||
WINTER, Anthony Ronald | Diretor | Tregeare House Tregeare PL15 8RE Launceston Cornwall | British | Director | 55109030001 |
SOLOR CARE HOMES LTD possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Criado em 25/01/2013 Entregue em 04/02/2013 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of accession | Criado em 10/07/2009 Entregue em 22/07/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All of its rights title and interest from time to time in respect of any sums pursuant to the insurance policies, hedging agreements and relevant contract, see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 24/07/2003 Entregue em 01/08/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A rent deposit deed | Criado em 14/04/2000 Entregue em 25/04/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido The rent reserved by the lease and any other moneys due or becoming due to the chargee thereunder or payable by reason of any of the covenants or obligations on the part of the company or the conditions contained in the lease or on the part of the company under the deed and pursuant to any of the relevant documents (as defined) | |
Breve descrição The deposit sum and each and every debt represented by it.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fixed and floating charge | Criado em 14/04/2000 Entregue em 25/04/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies debts liabilities and obligations due or to become due by the chargor,the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee pursuant to any of the relevant documents (all as defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fixed and floating charge | Criado em 20/08/1999 Entregue em 02/09/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The leasehold property known as 703 burton road, midway, derbyshire all rights title interest and benefits contracts, book debts, equipment records and software the goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed relating to rent deposit in respect of a tenancy of premises known as 204 ashby road,burton upon trent,staffordshire DE15 olb | Criado em 15/01/1999 Entregue em 21/01/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the master lease dated 22ND september 1997 (as defined) and all other sums due thereunder under clauses 2 and 5 of this deed | |
Breve descrição The deposit of £4070 and any further sums from time to time standing to the credit of the account and all interest thereon at the bank of scotland,38 threadneedle st,london EC2P 2EA. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fixed and floating charge | Criado em 07/01/1999 Entregue em 21/01/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies,debts,liabilities and obligations due or to become due from the company or any other group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of rent deposit charge | Criado em 22/09/1997 Entregue em 07/10/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and this charge | |
Breve descrição The sum of £63,000 including such other monies and all interest therein standing to the credit of the account (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 22/09/1997 Entregue em 07/10/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company, or any other group company (as therein defined) or any one or more of them to the chargee on any account whatsoever including, without limitation, pursuant to any group relevant documents (as therein defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0