SOLOR CARE HOMES LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSOLOR CARE HOMES LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03092133
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SOLOR CARE HOMES LTD?

    • Atividades de cuidados residenciais para idosos e pessoas com deficiência (87300) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica SOLOR CARE HOMES LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SOLOR CARE HOMES LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ROBINIA CARE HOMES LIMITED11/09/199511/09/1995
    TEMPLECO 270 LIMITED17/08/199517/08/1995

    Quais são as últimas contas de SOLOR CARE HOMES LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2014

    Qual é o status da última declaração anual para SOLOR CARE HOMES LTD?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para SOLOR CARE HOMES LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 30/06/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/07/2015

    Estado do capital em 02/07/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Estado do capital em 09/04/2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Nomeação de Mr Philip Andre Sealey como diretor em 09/01/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kevin Wei Roberts como diretor em 09/01/2015

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2014

    16 páginasAA

    Declaração anual preparada até 30/06/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/07/2014

    Estado do capital em 01/07/2014

    • Capital: GBP 59,902
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2013

    15 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD* em 25/09/2013

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Kevin Wei Roberts como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Bruce Mckendrick como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 30/06/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    legacy

    28 páginasMG01

    Resoluções

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2012

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 30/06/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Nomeação de Bruce Mckendrick como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Andrew Winning como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Philip Sealey como secretário

    3 páginasAP03

    Término da nomeação de Christina Bailey como secretário

    2 páginasTM02

    Quem são os diretores de SOLOR CARE HOMES LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SEALEY, Philip
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Secretário
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    British168863700001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Diretor
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Secretary45325360001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Diretor
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishNone73772160002
    ARTHUR, Simon David
    128 The Oaks
    RG14 7UZ Newbury
    Berkshire
    Secretário
    128 The Oaks
    RG14 7UZ Newbury
    Berkshire
    BritishSolicitor79790640004
    BAILEY, Christina
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    Secretário
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    148286600001
    BAKER, Michael Anthony
    23 Polo Way
    Chesterfield
    CT5 3LA Whitstable
    Kent
    Secretário
    23 Polo Way
    Chesterfield
    CT5 3LA Whitstable
    Kent
    BritishDirector44501470001
    DOLEMAN, Kit
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Secretário
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    BritishCeo135491940001
    FRY, David
    Woodbine Cottage
    Vale Of Health
    NW3 1AX London
    Secretário
    Woodbine Cottage
    Vale Of Health
    NW3 1AX London
    BritishFinancial Director90720170001
    HARRISON, Adam Chapman
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    Secretário
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    BritishFinance Director77287140001
    MCGINN, Benjamin John
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    Secretário
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    BritishFinancial Director61212620003
    SPOORS, Mark
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    Secretário
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    BritishFinance Director120580980001
    TAYLOR, Timothy John
    13 Dagden Road
    Shalford
    GU4 8DD Guildford
    Surrey
    Secretário nomeado
    13 Dagden Road
    Shalford
    GU4 8DD Guildford
    Surrey
    British900009360001
    THORTON, Martin Hewson
    18 Church Road
    Silverton
    EX5 4HS Exeter
    Devon
    Secretário
    18 Church Road
    Silverton
    EX5 4HS Exeter
    Devon
    BritishSolicitor84509000001
    WAGSTAFF, Elizabeth Anne
    35 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Secretário
    35 St James Square
    BA1 2TT Bath
    British43422820002
    BAINS, Satwant Singh
    8 Waldemar Road
    Wimbledon
    SW19 7LJ London
    Diretor
    8 Waldemar Road
    Wimbledon
    SW19 7LJ London
    BritishChief Executive Officer94530450001
    BAKER, Michael Anthony
    23 Polo Way
    Chesterfield
    CT5 3LA Whitstable
    Kent
    Diretor
    23 Polo Way
    Chesterfield
    CT5 3LA Whitstable
    Kent
    BritishDirector44501470001
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Diretor
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector138044110001
    BROOKES, Richard Dennis
    Cress Farm House
    High Street
    CV37 8EA Welford On Avon
    Warwickshire
    Diretor
    Cress Farm House
    High Street
    CV37 8EA Welford On Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishChart Surveyor81219580001
    DOLEMAN, Kit
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo135491940001
    DURRANCE, Philip Walter
    34 Hamilton Gardens
    St Johns Wood
    NW8 9PU London
    Diretor nomeado
    34 Hamilton Gardens
    St Johns Wood
    NW8 9PU London
    British900009350001
    FORD, Katherine Frances
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    Diretor
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector138136380001
    FRY, David
    Woodbine Cottage
    Vale Of Health
    NW3 1AX London
    Diretor
    Woodbine Cottage
    Vale Of Health
    NW3 1AX London
    EnglandBritishFinancial Director90720170001
    HARRISON, Adam Chapman
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    Diretor
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    BritishFinance Director77287140001
    KING, Paul Dennis Arthur
    Mere Combe Farm
    Bath Road Blagdon
    BS18 6SG North Somerset
    Diretor
    Mere Combe Farm
    Bath Road Blagdon
    BS18 6SG North Somerset
    BritishAccountant60873180001
    MCGINN, Benjamin John
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    Diretor
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    United KingdomBritishFinance Director61212620003
    MCKENDRICK, Bruce
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    Diretor
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    UkBritishNone157088060001
    PERRY, Roland Robert Joseph
    Race Farm Lane
    Kingston
    OX13 5AY Bagpuize
    Race Farm
    Oxfordshire
    Diretor
    Race Farm Lane
    Kingston
    OX13 5AY Bagpuize
    Race Farm
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector139021390001
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Diretor
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishCompany Director72030660002
    SPOORS, Mark
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    Diretor
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    BritishFinance Director120580980001
    TAYLOR, Timothy John
    13 Dagden Road
    Shalford
    GU4 8DD Guildford
    Surrey
    Diretor nomeado
    13 Dagden Road
    Shalford
    GU4 8DD Guildford
    Surrey
    British900009360001
    VON MALACHOWSKI, Glen
    Canada Farm House
    Captains Hill
    BA9 6HA Kinwartin
    Alcester
    Diretor
    Canada Farm House
    Captains Hill
    BA9 6HA Kinwartin
    Alcester
    EnglandBritishDirector66391980002
    WAGSTAFF, Elizabeth Anne
    Abbey Rectory
    Park Lane
    BA1 2XH Bath
    Diretor
    Abbey Rectory
    Park Lane
    BA1 2XH Bath
    BritishDirector43422820004
    WINTER, Anthony Ronald
    Tregeare House
    Tregeare
    PL15 8RE Launceston
    Cornwall
    Diretor
    Tregeare House
    Tregeare
    PL15 8RE Launceston
    Cornwall
    BritishDirector55109030001

    SOLOR CARE HOMES LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 25/01/2013
    Entregue em 04/02/2013
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 04/02/2013Registro de uma garantia (MG01)
    Deed of accession
    Criado em 10/07/2009
    Entregue em 22/07/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All of its rights title and interest from time to time in respect of any sums pursuant to the insurance policies, hedging agreements and relevant contract, see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transações
    • 22/07/2009Registro de uma garantia (395)
    • 25/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 24/07/2003
    Entregue em 01/08/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 01/08/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A rent deposit deed
    Criado em 14/04/2000
    Entregue em 25/04/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The rent reserved by the lease and any other moneys due or becoming due to the chargee thereunder or payable by reason of any of the covenants or obligations on the part of the company or the conditions contained in the lease or on the part of the company under the deed and pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Breve descrição
    The deposit sum and each and every debt represented by it.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Phf Securities No.3 Limited
    Transações
    • 25/04/2000Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 14/04/2000
    Entregue em 25/04/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies debts liabilities and obligations due or to become due by the chargor,the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee pursuant to any of the relevant documents (all as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Phf Securities No.3 Limited
    Transações
    • 25/04/2000Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 20/08/1999
    Entregue em 02/09/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The leasehold property known as 703 burton road, midway, derbyshire all rights title interest and benefits contracts, book debts, equipment records and software the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transações
    • 02/09/1999Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed relating to rent deposit in respect of a tenancy of premises known as 204 ashby road,burton upon trent,staffordshire DE15 olb
    Criado em 15/01/1999
    Entregue em 21/01/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the master lease dated 22ND september 1997 (as defined) and all other sums due thereunder under clauses 2 and 5 of this deed
    Breve descrição
    The deposit of £4070 and any further sums from time to time standing to the credit of the account and all interest thereon at the bank of scotland,38 threadneedle st,london EC2P 2EA. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transações
    • 21/01/1999Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 07/01/1999
    Entregue em 21/01/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies,debts,liabilities and obligations due or to become due from the company or any other group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transações
    • 21/01/1999Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of rent deposit charge
    Criado em 22/09/1997
    Entregue em 07/10/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and this charge
    Breve descrição
    The sum of £63,000 including such other monies and all interest therein standing to the credit of the account (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transações
    • 07/10/1997Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 22/09/1997
    Entregue em 07/10/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company, or any other group company (as therein defined) or any one or more of them to the chargee on any account whatsoever including, without limitation, pursuant to any group relevant documents (as therein defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transações
    • 07/10/1997Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0