SUPERIOR PRODUCE LIMITED

SUPERIOR PRODUCE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSUPERIOR PRODUCE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03107069
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    GROWERS CHOICE LIMITED05/12/199505/12/1995
    GREENSENSE LIMITED27/09/199527/09/1995

    Quais são as últimas contas de SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/03/2014

    Qual é o status da última declaração anual para SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/03/2014

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/08/2014 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/09/2014

    Estado do capital em 01/09/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Resoluções

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 31/08/2013 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/09/2013

    Estado do capital em 10/09/2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* em 10/09/2013

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/03/2013

    5 páginasAA

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    Diversos

    Section 519
    2 páginasMISC

    Término da nomeação de Christopher Thomas como diretor

    2 páginasTM01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/09/2012 para 31/03/2013

    1 páginasAA01

    Término da nomeação de Steve Wood como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 31/08/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Gavin Cox em 01/11/2011

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Steve Wood em 01/11/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Gavin Cox em 01/11/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Christopher Thomas em 01/11/2011

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Food Partners House Poyle Road Colnbrook, Slough England SL3 0EN England* em 13/11/2012

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 01/10/2011

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Retirada do pedido de exclusão da sociedade

    2 páginasDS02

    Quem são os diretores de SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Secretário
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756720001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Diretor
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Secretário
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150501100001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretário
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    VINCENT, Guy Wyndham
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Secretário
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    British70893430002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Secretário
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    SECRETAIRE LIMITED
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    Secretário nomeado
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    900011490001
    BROWN, Kevin Thomas
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Diretor nomeado
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish900008020001
    CHISAMBI, Rodgers Yalamila
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Diretor
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Zambian77986900001
    FEE, Paul
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    Diretor
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    British55281590001
    GUY, David Simon
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Diretor
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British119214340001
    HALL, Fraser Scott
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Diretor
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British4578740001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Diretor
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish83660790002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Diretor
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MELLORS, William Peter Stewart
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    Diretor
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    British107055640001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Diretor
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    NELSON, Finlay Macarthur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    Diretor
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    EnglandBritish132363820001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Diretor
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Diretor
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Diretor
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    SINCLAIR, John Frederick
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Diretor
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British46006710001
    SMITH, Andrew Macdonald
    Chimneys
    Westbury Road
    BR1 2QB Bromley
    Kent
    Diretor
    Chimneys
    Westbury Road
    BR1 2QB Bromley
    Kent
    British74660050001
    TAYLOR, Agatha
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British58350880001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Diretor
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Diretor
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WEBB, Robert John
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    Diretor
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    British65669490001
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Diretor
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    WORT, Edward George
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    Diretor
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    British77987180001

    SUPERIOR PRODUCE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 21/04/2008
    Entregue em 02/05/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transações
    • 02/05/2008Registro de uma garantia (395)
    • 15/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture accession deed
    Criado em 16/02/2007
    Entregue em 05/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)(the Security Agent)
    Transações
    • 05/03/2007Registro de uma garantia (395)
    • 15/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 08/01/2004
    Entregue em 10/01/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 10/01/2004Registro de uma garantia (395)
    • 22/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/03/1999
    Entregue em 01/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 01/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 22/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 03/12/1996
    Entregue em 07/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H or l/h property k/a units 187-189 and 190-192A western international market heston l/b of hounslow & all buildings & structures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Superior Foods Limited
    Transações
    • 07/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 17/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 13/12/1995
    Entregue em 19/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 19/12/1995Registro de uma garantia (395)
    • 05/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0