GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED

GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03114400
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SHAREHOLDER COMMUNICATIONS PLC20/02/199820/02/1998
    SHAREHOLDER COMMUNICATIONS CORPORATION (UK) PLC16/10/199516/10/1995

    Quais são as últimas contas de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2013

    Qual é o status da última declaração anual para GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Estado do capital em 29/04/2014

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 30/06/2013

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 16/10/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Nomeação de Mr Christopher Andrew Mills como diretor

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2012

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 16/10/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    legacy

    9 páginasMG02

    legacy

    7 páginasMG02

    legacy

    7 páginasMG02

    Contas anuais preparadas até 30/06/2011

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 16/10/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Nomeação de Mr Jonathan Dolbear como secretário

    1 páginasAP03

    Contas anuais preparadas até 30/06/2010

    15 páginasAA

    Nomeação de Nazir Sarkar como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Christopher Morris como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 16/10/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Término da nomeação de James Hood como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2009

    15 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield em 15/04/2010

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Secretário
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    South African105560560001
    DOLBEAR, Jonathan
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    Secretário
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    161908810001
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Diretor
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    United KingdomSouth African105560560001
    MILLS, Christopher Andrew
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    Diretor
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    EnglandBritish178211930001
    OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    Diretor
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    EnglandBritish116701010001
    SARKAR, Nazir
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    Diretor
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    United KingdomBritish157131040003
    COE, Lorraine Elizabeth
    3 St Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    Secretário
    3 St Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    British24485080001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Secretário
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    British83564940010
    DEVON, David John
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    Secretário
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    British7756250002
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Secretário
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    British60270470001
    GREENHALGH, John William
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    Secretário
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    British15630560001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Secretário
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    British53858740001
    BAILES, David Delisle
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Diretor
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    South African92919610001
    BORONKAY, Ronald
    17 State Street
    NY 1000Y New York
    Usa
    Diretor
    17 State Street
    NY 1000Y New York
    Usa
    Us Citizen62203530002
    CHANDOHA, Walter Sam
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Diretor
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    American62029490001
    CHAPMAN, Robert William Frederick
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    Diretor
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish110216200001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Diretor
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritish83564940010
    CROSBY, William Stuart
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Diretor
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Australian108743530001
    DEVON, David John
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    Diretor
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    British7756250001
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Diretor
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    UkBritish60270470001
    GREENHALGH, John William
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    Diretor
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    United KingdomBritish15630560001
    HOOD, James Terence
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    Diretor
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritish189833420001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    British53858740001
    MARSHALL, Timothy Thomas
    9 Trentishoe Mansions
    90 Charing Cross Road
    WC2H 0JE London
    Diretor
    9 Trentishoe Mansions
    90 Charing Cross Road
    WC2H 0JE London
    American87963030001
    MILLER, Alexander
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Diretor
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Us Citizen57588460002
    MORRIS, Christopher John
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Diretor
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    AustraliaAustralian114812600001
    PALMER, Samantha
    17 Athelstan Road
    ME4 6EJ Chatham
    Kent
    Diretor
    17 Athelstan Road
    ME4 6EJ Chatham
    Kent
    British52210680002
    SMITH, Jason Leigh
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Diretor
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Australian115310950001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Diretor
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish113777700001

    GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Pledge agreement
    Criado em 22/09/2003
    Entregue em 03/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Provident Bank
    Transações
    • 03/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 22/08/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 22/09/2003
    Entregue em 26/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Provident Bank (The "Agent")
    Transações
    • 26/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 22/08/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 16/06/1998
    Entregue em 25/06/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the guarantee or the credit agreement of even date
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Provident Bank
    Transações
    • 25/06/1998Registro de uma garantia (395)
    • 22/08/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0