CHUBB LONDON GROUP LIMITED

CHUBB LONDON GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCHUBB LONDON GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03115073
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ACE LONDON GROUP LIMITED14/07/199814/07/1998
    ACE UK LIMITED20/11/199520/11/1995
    3046TH SINGLE MEMBER SHELF TRADING COMPANY LIMITED19/10/199519/10/1995

    Quais são as últimas contas de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    10 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/09/2022

    9 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD para 30 Old Bailey London EC4M 7AU em 11/05/2022

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    16 páginasLIQ10

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/09/2021

    9 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/09/2020

    9 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/09/2019

    9 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP United Kingdom para Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD em 22/10/2018

    2 páginasAD01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP

    2 páginasAD02

    Declaração de solvência

    6 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 14/09/2018

    LRESSP

    Declaração de confirmação apresentada em 02/06/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    14 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 02/06/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 02/06/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/06/2016

    Estado do capital em 16/06/2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Detalhes do secretário alterados para Ace London Services Limited em 30/03/2016

    1 páginasCH04

    Memorando e estatutos

    25 páginasMA

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed ace london group LIMITED\certificate issued on 30/03/16
    2 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name30/03/2016

    Alteração do nome" por disposição nos estatutos

    NM04

    Endereço do domicílio registado alterado de Ace Building 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP para 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP em 25/02/2016

    1 páginasAD01

    Detalhes do secretário alterados para Ace London Services Limited em 24/02/2016

    1 páginasCH04

    Nomeação de Ashley Craig Mullins como diretor em 05/02/2016

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CHUBB LONDON SERVICES LIMITED
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Secretário
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro03115073
    73849550003
    HAMMOND, Mark Kent
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Diretor
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomAmerican174190760002
    KENDRICK, Andrew James
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Diretor
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomBritish62276900004
    MULLINS, Ashley Craig
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Diretor
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    EnglandAustralian205193200001
    BROWN, Alexander Johnston
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    Secretário
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    British2569760001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secretário
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretário nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    CHARMAN, John Robert
    Dell House Wilderness Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Dell House Wilderness Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    British14016810001
    CIGELNIK, Randi Lyn
    28 Pilgrims Lane
    NW3 1SN London
    Diretor
    28 Pilgrims Lane
    NW3 1SN London
    American88380810001
    CURTIS, Philippa Mary
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    Diretor
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    United KingdomBritish40995560001
    CURTIS, Philippa Mary
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    Diretor
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    United KingdomBritish40995560001
    DUPERREAULT, Brian
    Paget Hall
    15 Harbour Road
    Paget Pg02
    Bermuda
    Diretor
    Paget Hall
    15 Harbour Road
    Paget Pg02
    Bermuda
    American75259420003
    DUPERREAULT, Brian
    Sanctuary
    55 Harbour Road
    PG02 Paget
    Bermuda
    Diretor
    Sanctuary
    55 Harbour Road
    PG02 Paget
    Bermuda
    BermudaU.S. Citizen75259420002
    FIELD, Roger Anthony
    South View
    The Green
    TN11 8QR Leigh
    Kent
    Diretor
    South View
    The Green
    TN11 8QR Leigh
    Kent
    EnglandBritish101275950001
    FREDERICO, Dominic J
    4 Windy Hollow Road
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    United States
    Diretor
    4 Windy Hollow Road
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    United States
    American75112830001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Diretor
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GOODMAN, Leslie David
    19 Tideswell Road
    Putney
    SW15 6LJ London
    Diretor
    19 Tideswell Road
    Putney
    SW15 6LJ London
    EnglandBritish7683930001
    HAMPTON, Clifford Samuel Herbert
    Marshgate House
    36 Sheen Road
    TW9 1AW Richmond
    Surrey
    Diretor
    Marshgate House
    36 Sheen Road
    TW9 1AW Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish36483720001
    KENDRICK, Andrew James
    23 Klea Avenue
    SW4 9HG London
    Diretor
    23 Klea Avenue
    SW4 9HG London
    United KingdomBritish62276900003
    KRAMER, Donald
    1 Beekman Place
    New York 10022
    Usa
    Diretor
    1 Beekman Place
    New York 10022
    Usa
    Us50057850001
    LANGE, Michael Clemens Anton
    1 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    Diretor
    1 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    American48641670001
    LLOYD, Jeffrey John
    5 Scotia Building
    Jardine Road
    E1 9WA London
    Diretor
    5 Scotia Building
    Jardine Road
    E1 9WA London
    British45902540002
    LOSCHERT, William James
    Flat 1
    45 Cadogan Square
    SW1X 0HX London
    Diretor
    Flat 1
    45 Cadogan Square
    SW1X 0HX London
    United KingdomAmerican51396620001
    POOLE, David Charles, The Lord
    19 Keyes Road
    NW2 3XB London
    Diretor
    19 Keyes Road
    NW2 3XB London
    United KingdomBritish84127430001
    SCHMALZRIEDT, Gary
    188 East 76th Street
    Penthouse A
    New York 1002
    United States
    Diretor
    188 East 76th Street
    Penthouse A
    New York 1002
    United States
    American76185280007
    SMITH, Michael Gordon
    9 Fournier Street
    E1 6QE London
    Diretor
    9 Fournier Street
    E1 6QE London
    British58386920001
    UNDERHILL, Kenneth Landers Hoffman
    Ace Building
    100 Leadenhall Street London
    EC3A 3BP
    Diretor
    Ace Building
    100 Leadenhall Street London
    EC3A 3BP
    EnglandBritish132498240001
    WILLIAMS, Graham David
    18 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Diretor
    18 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    British6283470002
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Diretor nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001760001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    06/04/2016
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro03600577
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    CHUBB LONDON GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 28/01/2010
    Entregue em 03/02/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re ace london group limited. Clients premium account. Account number 90535192.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/02/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Deposit trust deed (third party)(the "trust deed")
    Criado em 22/10/1997
    Entregue em 12/11/1997
    Pendente
    Montante garantido
    All the underwriting obligations of the company incurred by the company as an underwriting member of the society at any time before the termination date 9BEING the 80TH anniversary of the date of the trust deed) including obligations to the society and the trustees (as defined)
    Breve descrição
    All such moneys/other property approved by the council of lloyd's as have been paid or transferred by the depositor or trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871 by the Name of Lloyd's,as Trustees
    Transações
    • 12/11/1997Registro de uma garantia (395)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 27/11/1996
    Entregue em 09/12/1996
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over the deposit being all money in any currency deposited with the bank pursuant to the deposit being:- barclays bank PLC re ace UK limited treasurers sterling bid deposit no 42727855. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1996Registro de uma garantia (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Criado em 26/11/1996
    Entregue em 11/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 11/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge over deposit
    Criado em 27/03/1996
    Entregue em 05/04/1996
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the deed of counter indemnity and/or the guarantee (both as therein defined)
    Breve descrição
    All monies at any time standing to the credit of the account of the company in the books of bank of scotland treasury services PLC together with all interest and other amount accruing on such sums.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 05/04/1996Registro de uma garantia (395)

    CHUBB LONDON GROUP LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    14/09/2018Início da liquidação
    17/03/2023Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Profissional
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Neil John Mather
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Profissional
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Profissional
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0