CARDCAST LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCARDCAST LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03119366
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CARDCAST LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica CARDCAST LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CARDCAST LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CARDCAST PLC04/04/199604/04/1996
    CARDCAST INFORMATION SYSTEMS LIMITED22/02/199622/02/1996
    SHELFCO (NO.1144) LIMITED27/10/199527/10/1995

    Quais são as últimas contas de CARDCAST LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Quais são as últimas submissões para CARDCAST LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Pedido de insolvência

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 páginasLIQ MISC

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/07/2017

    8 páginasLIQ03

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    7 páginasLIQ13

    Nomeação de um liquidador voluntário

    14 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    17 páginasLIQ10

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/07/2016

    7 páginas4.68

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 28/07/2015

    LRESSP

    Endereço do domicílio registado alterado de Red House Brookwood Woking Surrey GU24 0BL para 7 More London Riverside London SE1 2RT em 21/07/2015

    2 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 27/10/2014 com lista completa de acionistas

    14 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/01/2015

    Estado do capital em 03/01/2015

    • Capital: GBP .4
    SH01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 18/09/2014

    • Capital: GBP 2,498,467
    4 páginasSH01

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Término da nomeação de Neshia Batchasingh como secretário em 11/09/2014

    2 páginasTM02

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 18/09/2014

    • Capital: GBP 0.40
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account and cancellation of capital redemption reserve 18/09/2014
    RES13

    Término da nomeação de Neshia Michelle Batchasingh como diretor em 12/08/2014

    2 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 6

    4 páginasMR04

    Nomeação de Ricardo Caupers como diretor

    3 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 27/10/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital25/11/2013

    Estado do capital em 25/11/2013

    • Capital: GBP 647,802
    SH01

    Quem são os diretores de CARDCAST LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CAUPERS, Ricardo
    King Street
    SW1Y 6RT London
    33
    United Kingdom
    Diretor
    King Street
    SW1Y 6RT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomPortuguese188764420001
    GIUSEPPETTI, Fabio Massimo
    15 Crick Road
    OX2 6QL Oxford
    Oxfordshire
    Diretor
    15 Crick Road
    OX2 6QL Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomItalian115927050001
    AINSWORTH-MORRIS, Richard
    21 Sarek Park
    NN4 9YA Northampton
    Northamptonshire
    Secretário
    21 Sarek Park
    NN4 9YA Northampton
    Northamptonshire
    British80972840001
    AMOS, Richard John
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    Secretário
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    British67950460002
    BATCHASINGH, Neshia
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    Secretário
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    169879280001
    COOKE, Oliver Charles
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    Secretário
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    British3643340001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Secretário
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    British45345090004
    GOOD, Thomas William
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    Secretário
    Kyndling
    39a Cobbetts Walk
    GU24 9DU Bisley
    Surrey
    British21310620003
    HAYES, Kevin Andrew
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    Secretário
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    British29737760001
    MARCHANT, Elizabeth Jane
    10 Harelands Close
    Horsell
    GU21 4NX Woking
    Surrey
    Secretário
    10 Harelands Close
    Horsell
    GU21 4NX Woking
    Surrey
    British62140800001
    POOLEY, Graham Neil
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    Secretário
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    British38288020001
    WIGHTMAN, Iain Charles
    65 Marefield
    Lower Earley
    RG6 3DZ Reading
    Berkshire
    Secretário
    65 Marefield
    Lower Earley
    RG6 3DZ Reading
    Berkshire
    British81324370001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Secretário nomeado
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    AMOS, Richard John
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    22 Collens Road
    AL5 2AJ Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67950460002
    BATCHASINGH, Neshia Michelle
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    Diretor
    Red House
    Brookwood
    GU24 0BL Woking
    Surrey
    United KingdomBritish150222160001
    CALLAHAN, Stephen James
    The White House
    Charney Bassett
    OX12 0EU Wantage
    Oxfordshire
    Diretor
    The White House
    Charney Bassett
    OX12 0EU Wantage
    Oxfordshire
    British59241360001
    CAUNTER, Nicholas John
    Appletrees 7 Lashmere
    Copthorne
    RH10 3RR Crawley
    West Sussex
    Diretor
    Appletrees 7 Lashmere
    Copthorne
    RH10 3RR Crawley
    West Sussex
    British100149070001
    CLUMP, Carlyle Cyril
    Block 11
    Portomaso
    PTM 01 St Julians
    Apartment 1112
    Malta
    Diretor
    Block 11
    Portomaso
    PTM 01 St Julians
    Apartment 1112
    Malta
    MaltaBritish61613210002
    COOKE, Oliver Charles
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    Diretor
    Solelands Farm
    RH20 2LG West Chiltington
    United KingdomBritish3643340001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish45345090004
    GOOD, Thomas William
    5 Burnet Close
    GU24 9PB West End
    Surrey
    Diretor
    5 Burnet Close
    GU24 9PB West End
    Surrey
    British21310620004
    NEVILLE, Roger Drummond
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    Diretor
    97 Rous Road
    IG9 6BU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritish35529130001
    PARSONS, Robert Michael Featherstonehaugh
    Three Hills House
    Epwell
    OX15 6LG Banbury
    Oxfordshire
    Diretor
    Three Hills House
    Epwell
    OX15 6LG Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish51846740001
    POOLEY, Graham Neil
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    Diretor
    Orakau
    12 Willow Walk
    GU28 0EY Petworth
    West Sussex
    British38288020001
    POULTON, Christopher
    Wildbarn 1a Brookside
    Orwell
    SG8 5TQ Royston
    Hertfordshire
    Diretor
    Wildbarn 1a Brookside
    Orwell
    SG8 5TQ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish65823790001
    RAVEN, Brian Kenneth
    Foxwood 10 Badgers Hill
    GU25 4SB Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Foxwood 10 Badgers Hill
    GU25 4SB Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish156746380001
    RICHARDSON, Ernest Arthur
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish5161170001
    TURNER, Matthew Charles
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    Diretor
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish115927000001
    WHITTAKER, Nigel
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    Diretor
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    British65180900001
    WHITTAKER, Nigel
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    Diretor
    176 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 3BU London
    British65180900001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Diretor nomeado
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    CARDCAST LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    New jersey law pledge agreement
    Criado em 22/11/2012
    Entregue em 26/11/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A first security interest in the collateral see image for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 26/11/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 08/08/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 18/09/2012
    Entregue em 22/09/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 22/09/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 08/08/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    An accession deed
    Criado em 23/02/2007
    Entregue em 15/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first legal mortgage all real property by way of first fixed charge all shares all dividends interest sand other monies and each of its accounts by way of assignment the proceeds of any claim under any insurance policy and all related rights and all rights and claims in relation to any assigned account by way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/03/2007Registro de uma garantia (395)
    • 23/09/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Stock pledge agreement
    Criado em 11/01/2000
    Entregue em 28/01/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Any and all present and future sums obligations and liabilities of retail decisions PLC (the parent) and any other group company nominated as an additional borrower by the parent if any to the chargee under or in connection with the credit agreement or any of the other financing documents and all liabilities of the pledgor (the company) under the pledge
    Breve descrição
    The pledged collateral which means 100 shares of common stock no par value in transaction billing resources inc and all cash securities dividends proceeds and other property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 28/01/2000Registro de uma garantia (395)
    • 14/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture made between the company and national westminster bank PLC (the security trustee)
    Criado em 11/01/2000
    Entregue em 17/01/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations and liabilities whether present and future, actual or contingent due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 17/01/2000Registro de uma garantia (395)
    • 14/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 19/02/1998
    Entregue em 20/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations and liabilites whether present or future actual or contingent which may at the date of the debenture or at any time thereafter be or become owing or incurred by the company to the chargee as security trustee,issuing bank and the banks under or pursuant to any of a credit agreement dated 23RD january 1998,a fees letter,and any guarantees and any debenture executed as security for any of the obligations and liabilities of the company and the other companies within the same group under any of the foregoing documents (together the "financing documents") (the "secured obligations")
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 20/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 02/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CARDCAST LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    28/07/2015Início da liquidação
    13/12/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0