OFFICE PROPERTIES PL LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | OFFICE PROPERTIES PL LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Liquidação |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03125437 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
- Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias
Onde fica OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MWB PROPERTY LIMITED | 01/07/2008 | 01/07/2008 |
| MARYLEBONE WARWICK BALFOUR GROUP PLC | 01/07/1997 | 01/07/1997 |
| EX-LANDS PROPERTIES PLC | 08/11/1995 | 08/11/1995 |
Quais são as últimas contas de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2018 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2019 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Última declaração de confirmação elaborada até | 31/10/2019 |
| Próxima declaração de confirmação vence | 14/11/2019 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 31/10/2018 |
| Vencido | Sim |
Quais são as últimas submissões para OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomeação de Ms Joanne Constance Bushell como diretor em 17/10/2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Wayne David Berger como diretor em 03/10/2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 20/06/2025 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 20/06/2024 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Nomeação de Mr. Wayne David Berger como diretor em 31/05/2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr. Gavin Steven Phillips como diretor em 31/05/2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Richard Morris como diretor em 31/05/2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 20/06/2023 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 20/06/2022 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 20/06/2021 | 20 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/09/2020 | 18 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Término da nomeação de Peter David Edward Gibson como diretor em 28/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 6 Snow Hill London EC1A 2AY para Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW em 07/10/2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Renúncia de um liquidatário | 3 páginas | LIQ06 | ||||||||||
Renúncia de um liquidatário | 3 páginas | LIQ06 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 1 Burwood Place London W2 2UT England para 6 Snow Hill London EC1A 2AY em 22/07/2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Estado de situação patrimonial | 10 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/10/2018 com atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/06/2017 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSHELL, Joanne Constance | Diretor | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | South Africa | British | 341942760001 | |||||||||
| PHILLIPS, Gavin Steven, Mr. | Diretor | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | British | 324092780001 | |||||||||
| CAVE, Ian Bruce | Secretário | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | British | 102741680001 | ||||||||||
| CROSSLEY, James Daniel | Secretário | 34 Bellevue Road CM12 9HB Billericay Essex | British | 29059900001 | ||||||||||
| CITY GROUP PLC | Secretário | City Road EC1Y 2AG London 30 England |
| 35794270004 | ||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| PITSEC LIMITED | Secretário | Castle Street RG1 7SR Reading 47 England |
| 38734010001 | ||||||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Diretor | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||||||
| BERGER, Wayne David, Mr. | Diretor | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | Canadian | 323759890001 | |||||||||
| BIBRING, Michael Albert | Diretor | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||||||
| BLURTON, Andrew Francis | Diretor | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 53724380001 | |||||||||
| BOURNE, Graham Alexander | Diretor | Le Roccabella 24 Avenue Princess Grace Monte Carlo 98000 Monaco | United Kingdom | British | 76871220004 | |||||||||
| BOURNE, Robert Anthony | Diretor | 100 Cheyne Walk SW10 0DQ London | British | 70526160001 | ||||||||||
| BOUVIER, Alain Charles Patrice | Diretor | 32 Earls Court Square SW5 9DQ London | England | British | 24106110001 | |||||||||
| BURROW, Robert Philip | Diretor | 67 Brook Street W1K 4NJ London | England | British | 97252420005 | |||||||||
| CHENERY, Richard James | Diretor | Lower Slaughter GL54 2HP Cheltenham The Manor Cottage Gloucestershire United Kingdom | England | British | 146075610001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Diretor | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Diretor | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | England | British | 235422380001 | |||||||||
| HARRISON, John William | Diretor | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | 69263980002 | |||||||||
| MARSHALL, David Courtnall | Diretor | Savannah House 32 Sherwood Road 4051 Durban North South Africa | South Africa | British | 132056360001 | |||||||||
| MORRIS, Richard | Diretor | Burwood Place W2 2UT London 1 England | England | British | 190653350001 | |||||||||
| MYERSON, Brian Alan | Diretor | 52 Winnington Road N2 0TY London | British | 63023520001 | ||||||||||
| PARKER, Christopher John | Diretor | Hill Place Station Road CM8 3JN Wickham Bishops Essex | British | 8218630001 | ||||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Diretor | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Diretor | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| SANDERSON, Eric Fenton | Diretor | 10 Harelaw Road EH13 0DR Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 126848980001 | |||||||||
| SHASHOU, Joseph Saleem | Diretor | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | 51723030002 | |||||||||
| SINGH, Jagtar | Diretor | West Garden Place Kendal Street W2 2AQ London 1 | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||||||
| STARN, William Robert | Diretor | City Road EC1Y 2AG London 30 | England | American | 154007330001 | |||||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Diretor nomeado | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 | |||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Diretor | 120 East Road N1 6AA London | 38524190001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marley Acquisitions Limited | 11/07/2017 | Burwood Place W2 2UT London 1 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Mwb Serviced Office Holdings Limited (In Liquidation) | 06/04/2016 | Little New Street EC4A 3TR London Hill House England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
OFFICE PROPERTIES PL LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Criado em 01/08/2008 Entregue em 13/08/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Entire right, title and interest in and to the 46,951,379 ordinary shares with a nominal value of £0.01 in the capital of mwb business exchange PLC together with all other shares in the capital of mwb business exchange PLC see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 31/03/2005 Entregue em 14/04/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge | Criado em 03/06/2003 Entregue em 16/06/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição By way of first fixed charge all inter-company debts. All the chargor's right, title and interest, present and future, in and to all inter-company debts. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge over shares | Criado em 07/08/2002 Entregue em 14/08/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Subordination agreement | Criado em 30/05/2002 Entregue em 10/06/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Any amounts held on trust for the agent towards the payment of all the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Subordination deed between 140 park lane limited flatford limited and flatford (no.2) limited as the obligors the company and nwb (park lane) limited as original junior creditors and the bank | Criado em 08/01/2002 Entregue em 18/01/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A security interest over the "junior liabilities". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Share charge | Criado em 28/08/1997 Entregue em 12/09/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from mwb (warwick road) limited to the chargee in connection with the loan agreement or any security document | |
Breve descrição By way of fixed charge the investments and all dividends interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 05/02/1996 Entregue em 09/02/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
OFFICE PROPERTIES PL LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de credores |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0