THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD

THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03143505
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    • Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias

    Onde fica THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    Endereço do escritório registrado
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    E.O.G. (UK) LTD09/05/200609/05/2006
    HQ EXECUTIVE OFFICES (UK) LTD29/12/199729/12/1997
    HQ SERVICED OFFICES (UK) LIMITED21/02/199621/02/1996
    MULCONE ASSOCIATES LIMITED04/01/199604/01/1996

    Quais são as últimas contas de THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2019
    Próximas contas vencem em31/12/2020
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Qual é o status da última declaração de confirmação para THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até03/01/2022
    Próxima declaração de confirmação vence17/01/2022
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até03/01/2021
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 19/12/2024

    9 páginasLIQ03
    YDVDXAEX

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 19/12/2023

    8 páginasLIQ03
    YCW1TG22

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 19/12/2022

    8 páginasLIQ03
    YBX15R80

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para 33 st James's Square London SW1Y 4JS

    2 páginasAD02
    AAYRQ57E

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01
    YAV6B5BN

    Endereço do domicílio registado alterado de 33 st. James's Square London SW1Y 4JS para 30 Finsbury Square London EC2A 1AG em 05/01/2022

    2 páginasAD01
    YAJSGGC1

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600
    YAJSGG0I

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 20/12/2021

    LRESSP

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Nicholas John Pike como diretor em 19/02/2021

    1 páginasTM01
    X9YW6MPE

    Nomeação de Mr John Charles Drover como diretor em 19/02/2021

    2 páginasAP01
    X9YW6MMQ

    Declaração de confirmação apresentada em 03/01/2021 com atualizações

    4 páginasCS01
    X9VH7GOR

    Alteração dos detalhes de Eog Limited como pessoa com controlo significativo em 05/09/2019

    2 páginasPSC05
    X9VH7GNV

    Memorando e estatutos

    13 páginasMA
    A9K85SJ6

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Nomeação de Mr Nicholas John Pike como diretor em 11/12/2020

    2 páginasAP01
    X9K6UNP6

    Término da nomeação de William Robert Starn como diretor em 11/12/2020

    1 páginasTM01
    X9K6UMZM

    Término da nomeação de Jean-Michel Orieux como diretor em 11/12/2020

    1 páginasTM01
    X9K6UN61

    Término da nomeação de Satheeshan Sabendran como diretor em 11/12/2020

    1 páginasTM01
    X9K6UMWY

    Término da nomeação de Barry Rees como diretor em 11/12/2020

    1 páginasTM01
    X9K6UMUQ

    Término da nomeação de Conal O'hara como diretor em 15/10/2020

    1 páginasTM01
    X9GJOLZH

    Nomeação de Mr Jean-Michel Orieux como diretor em 03/02/2020

    2 páginasAP01
    X8Z0OSTH

    Declaração de confirmação apresentada em 03/01/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X8VUPB4J

    Nomeação de Mr Satheeshan Sabendran como diretor em 19/10/2018

    2 páginasAP01
    X8GK5TO3

    Nomeação de Mr Barry Rees como diretor em 19/10/2018

    2 páginasAP01
    X8GK5T3C

    Quem são os diretores de THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    STARN, William
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Secretário
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    256450550001
    DROVER, John Charles
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritishCompany Director115678450004
    BUTLER, Graham Kenneth
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Secretário
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    British7412880001
    BUTLER, Graham Kenneth
    Bel Air Sandy Lane
    HA6 3ES Northwood
    Middlesex
    Secretário
    Bel Air Sandy Lane
    HA6 3ES Northwood
    Middlesex
    British7412880001
    CAMERON, Alastair
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Secretário
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    164943250001
    LIVERSIDGE, Christine
    Flat 4 26 Lofting Road
    N1 1ET London
    Secretário
    Flat 4 26 Lofting Road
    N1 1ET London
    BritishCompany Secretary5944730001
    THIESSEN, Jueane
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Secretário
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    194210970001
    ALPHA SECRETARIAL LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Secretário nomeado
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900004510001
    DIPLEMA CORPORATE SERVICES LIMITED
    1 Gresham Street
    EC2V 7BU London
    Secretário
    1 Gresham Street
    EC2V 7BU London
    46485400001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secretário nomeado
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    ADAM, Ronald George
    Foxleas
    Farnham Lane
    GU27 1EU Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Foxleas
    Farnham Lane
    GU27 1EU Haslemere
    Surrey
    BritishDirector73959810001
    ALLPORT, Peter Robert
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    United KingdomBritishChartered Surveyor154297690001
    ALLPORT, Peter Robert
    The Little Manor House
    Witheridge Hill
    RG9 5PE Highmoor
    Oxfordshire
    Diretor
    The Little Manor House
    Witheridge Hill
    RG9 5PE Highmoor
    Oxfordshire
    United KingdomBritishEstate Agent154297690001
    BUTLER, Graham Kenneth
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    EnglandBritishChartered Accountant7412880001
    BUTLER, Graham Kenneth
    Bel Air Sandy Lane
    HA6 3ES Northwood
    Middlesex
    Diretor
    Bel Air Sandy Lane
    HA6 3ES Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant7412880001
    CAMERON, Alastair
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    United KingdomBritishChartered Accountant164757990001
    DROVER, John Charles
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    United KingdomBritishChief Executive115678450004
    ERIKSSON, Carl Johan
    Old Burlington Street
    W1S 2JJ London
    22-23
    England
    Diretor
    Old Burlington Street
    W1S 2JJ London
    22-23
    England
    United KingdomSwedishDirector180461240001
    FALLS, Robert Richard William
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    United KingdomBritishInvestment Banker16501250009
    FISHER, Tiffanie
    Loft E 87 Paul Street
    EC2A 4NQ London
    Diretor
    Loft E 87 Paul Street
    EC2A 4NQ London
    AmericanBanker113839170001
    GILES, Timothy Stacey
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    EnglandBritishSurveyor115678510002
    GRYGER, Gabriela
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    United KingdomPolishBanker113019990002
    HALPERN, Jon Lincoln
    10 Sylvanleigh Road
    Purchase
    New York
    10577
    Usa
    Diretor
    10 Sylvanleigh Road
    Purchase
    New York
    10577
    Usa
    AmericanCompany Director80620250001
    HARNED, Peter Clarke
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    United KingdomAmericanManaging Director125065690002
    HARRIS, Peter
    1052 Sequoia Lane
    Weston
    Florida
    33327
    Usa
    Diretor
    1052 Sequoia Lane
    Weston
    Florida
    33327
    Usa
    AmericanGeneral Counsel Executive82156030001
    KALLEVIG, Karsten August
    111 Belgrave Road
    SW1V 2BH London
    Diretor
    111 Belgrave Road
    SW1V 2BH London
    BritishPartner Grove Investors90005170001
    KERSHAW, Peter John Coombs
    Green Court
    14 Sandown Avenue
    KT10 9NT Esher
    Surrey
    Diretor
    Green Court
    14 Sandown Avenue
    KT10 9NT Esher
    Surrey
    BarbadosBritishCompany Director51322410002
    KERSHAW, Peter
    34 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Diretor
    34 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    BritishDirector51322410001
    KOW, Gabriel Choon Moi
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    EnglandBritishDirector183240330001
    KUSIN, Gary M
    4717 Wildwood
    Dallas
    Texas 75209
    United States Of America
    Diretor
    4717 Wildwood
    Dallas
    Texas 75209
    United States Of America
    United States Of AmericaAmericanServiced Offices Industry62201310001
    LEEK, Jason Charles
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    EnglandBritishChief Executive Officer184892890001
    MEAD, Richard Barwick
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishConsultant44255220002
    O'HARA, Conal
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    EnglandBritishChief Operating Officer220483490001
    ORIEUX, Jean-Michel
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    Diretor
    33 St. James's Square
    London
    SW1Y 4JS
    EnglandFrenchChief Executive252298370001

    Quem são as pessoas com controle significativo de THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Argyll Club (Holdco 1) Ltd
    St. James's Square
    SW1Y 4JS London
    33
    England
    06/04/2016
    St. James's Square
    SW1Y 4JS London
    33
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroEngland
    Número de registro04759437
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 19/10/2018
    Entregue em 26/10/2018
    Pendente
    Breve descrição
    N/A.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Situs Asset Management Limited as Security Agent
    Transações
    • 26/10/2018Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 25/07/2017
    Entregue em 08/08/2017
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Any freehold or leasehold property now vested in the company, and the company’s interest in any freehold or leasehold property acquired after the date of the charge.. For more details, please refer to the instrument.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 08/08/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 01/04/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 28/08/2013
    Entregue em 09/09/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Cbre Loan Servicing Limited (As Security Trustee)
    Transações
    • 09/09/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 15/09/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 30/08/2011
    Entregue em 07/09/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon the charged account being barclays bank PLC re E.O.G. (UK) LTD business premium account number 33070026.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/09/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 27/08/2013Todo o imóvel ou empresa foi liberado e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 26/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 19/07/2010
    Entregue em 26/07/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Cb Richard Ellis Loan Servicing Limited ("Security Trustee")
    Transações
    • 26/07/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 13/07/2013Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 26/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Supplemental security agreement
    Criado em 16/11/2009
    Entregue em 17/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the security created under the supplemental security agreementall the secured liabilities with full title guarantee a first leagl mortgage all buildings, fixtures fittings and plant and machinery on that property. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Goldman Sachs Credit Partners (Europe) LTD
    Transações
    • 17/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 26/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Security agreement
    Criado em 01/07/2005
    Entregue em 20/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The trust property, land, securities, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, floating charge all its assets; 1) 33 st jame's square, london SW1, t/n NGL703549, 2) 6-8 the square, stockley park, uxbridge, middlesex, unregistered, 3) 18B charles street, london W1J 5DU, t/n NGL835411. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Credit Suisse, London, as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transações
    • 20/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 24/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Charge
    Criado em 23/12/2004
    Entregue em 29/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All sums deposited or to be deposited together with all the interest in relation to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) PLC
    Transações
    • 29/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 07/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Charge on deposit
    Criado em 22/12/2004
    Entregue em 24/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The sum of £688,606.96 (the "deposit"). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 07/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Criado em 11/06/2003
    Entregue em 02/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 09/06/2003
    Entregue em 14/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 23/08/2001
    Entregue em 07/09/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/09/2001Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 15/05/1998
    Entregue em 21/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The company's obligations to the chargee under a lease dated 15TH may 19998
    Breve descrição
    The sum of £124,775 plus a further sum equal to vat of £21,835.63.
    Pessoas com direito
    • Swan Hill Developments Limited
    Transações
    • 21/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 16/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 15/05/1998
    Entregue em 21/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The company's obligations to the chargee under a lease dated 15TH may 1998
    Breve descrição
    The sum of £108,675 plus a further sum equal to the value added tax of £19,018.13.
    Pessoas com direito
    • Swan Hill Developments Limited
    Transações
    • 21/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of supplemental charge
    Criado em 18/02/1998
    Entregue em 26/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a debenture dated 18 november 1996
    Breve descrição
    All that l/h premises k/a 23 berkeley square london W1 and flat 2 and 3 46 bruton place london W1.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 26/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 22/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of supplemental charge
    Criado em 02/02/1998
    Entregue em 10/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a debenture dated 18 november 1996
    Breve descrição
    All that l/h premises k/a ventures house,prince street roundabout,bristol.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 22/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of supplemental charge
    Criado em 27/01/1998
    Entregue em 05/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the debenture dated 18TH november 1996
    Breve descrição
    L/H premises k/a premises on the basement ground floor second, third and fourth floors 18/24 garrick street london WC2. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 05/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 22/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of supplemental charge
    Criado em 01/04/1997
    Entregue em 07/04/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 18TH november 1996
    Breve descrição
    All the l/h premises k/a level 4 199 bishopsgate london EC2.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 07/04/1997Registro de uma garantia (395)
    • 22/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 18/11/1996
    Entregue em 18/11/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 18/11/1996Registro de uma garantia (395)
    • 22/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 01/04/1996
    Entregue em 11/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 1ST april 1996
    Breve descrição
    Four payments each of £26,250 (total deposit £105,000) to the chargee on 1.10.96, 1.01.97, 1.04.97 & 1.07.97 into the "deposit account" (as defined in the deed).
    Pessoas com direito
    • Frogmore Business Centres Limited
    Transações
    • 11/04/1996Registro de uma garantia (395)
    • 07/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 17/03/1996
    Entregue em 02/04/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 02/04/1996Registro de uma garantia (395)
    • 26/11/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    THE ARGYLL CLUB (MAYFAIR) LTD possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/12/2021Início da liquidação
    16/12/2021Data da declaração de solvência jurada
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profissional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0